PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03057012 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED?
- Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos (38210) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 3 Sidings Court White Rose Way DN4 5NU Doncaster England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 21 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Notification de Derbyshire Waste Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 feb 2025 | 2 páginas | PSC02 | ||||||
Cessation de Fcc Environment (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 feb 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 30 jun 2024 | 7 páginas | RP04CS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 20 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2024 sin actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||
| ||||||||
Modification des détails de Fcc Environment (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||
Nombramiento de Mr Fraser Mckenzie como director el 01 feb 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Vicente Federico Orts-Llopis como director el 31 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 20 páginas | AA | ||||||
Nombramiento de Mr Steven John Longdon como director el 02 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Cese del nombramiento de Paul Taylor como director el 01 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 20 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7RG a 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU el 01 abr 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||
Cese del nombramiento de Agustin Serrano Minchan como director el 11 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 25 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 26 páginas | AA | ||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||
Cese del nombramiento de Georgina Violet Crowhurst como secretario el 28 ene 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||
Cancelación total de la carga 030570120004 | 1 páginas | MR04 | ||||||
Nombramiento de Miss Georgina Violet Crowhurst como secretario el 15 oct 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||
¿Quiénes son los directivos de PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGDON, Steven John | Director | Sidings Court White Rose Way DN4 5NU Doncaster 3 England | England | British | 311975880001 | |||||
| MCKENZIE, Fraser Wilson | Director | Sidings Court White Rose Way DN4 5NU Doncaster 3 England | England | British | 318879230001 | |||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 15931960007 | ||||||
| BUNTON, Victoria | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 164514590001 | |||||||
| CALDER, Samantha Jane | Secretario | Cowslip Cottage Roade Hill Ashton NN7 2JH Northampton Northamptonshire | British | 75830790003 | ||||||
| CROWHURST, Georgina Violet | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 263556830001 | |||||||
| DE FEO, Caterina | Secretario | Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Ground Floor West, 900 United Kingdom | Italian | 140556050001 | ||||||
| DOWNES, Jane Claire | Secretario | 3 Oakleigh View Baildon BD17 5TP Shipley West Yorkshire | British | 48088850001 | ||||||
| FAVIER TILSTON, Claire | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 117647490002 | ||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Secretario | The Wing Jaggards House Jaggards Lane Neston SN13 9SF Corsham Wiltshire | British | 93743250001 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secretario | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 174531420001 | |||||||
| WATERHOUSE, Alan | Secretario | 2a Norwood Grove Birkenshaw BD11 2NP Bradford West Yorkshire | British | 24588340001 | ||||||
| WORRALL, Andrew James | Secretario | Walnut Lodge The Paddocks Thorpe Lea Gunthorpe NG14 7FG Nottingham | British | 41781000001 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| BLUNDELL, Derek John | Director | Les Chouettes Rue Du Douit GYL 2EH St Peter Port Guernsey Channel Islands | British | 43405290001 | ||||||
| BURNS, Phillip Wesley | Director | Flat 15 12 Bourchier Street W1D 4HZ London | United Kingdom | British | 160550800001 | |||||
| CASSELLS, Leslie James Davidson | Director | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 95347040005 | ||||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Director | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| HARDMAN, Steven Neville | Director | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 93743250006 | ||||||
| HUNTINGTON, John Michael | Director | Skelton Hall Skelton Lane Thorner LS14 1AE Leeds West Yorkshire | British | 102172280001 | ||||||
| JENNINGS, Stephen Nigel | Director | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 60681180004 | |||||
| KELLY, Robert David Lindsay | Director | Glanville House Alcester Road Wooton Wawen B95 6BQ Henley In Arden Warwickshire | England | Welsh | 161123860001 | |||||
| MEREDITH, James Robert | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West 900 Northamptonshire | British | 29339860005 | ||||||
| ORTS-LLOPIS, Vicente Federico | Director | Sidings Court White Rose Way DN4 5NU Doncaster 3 England | United Kingdom | Spanish | 147551840001 | |||||
| PRIOR, Ruth Catherine | Director | 56 Northchurch Road N1 4EJ London | United Kingdom | British | 92539490002 | |||||
| SANDY, Nigel Desmond Alexander | Director | 3 Collett Way BA11 2XN Frome Somerset | England | British | 6470660001 | |||||
| SERRANO MINCHAN, Agustin | Director | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West, 900 United Kingdom | Spain | Spanish | 140598310001 | |||||
| STEWART, Quentin Richard | Director | 62 Anchor Brew House Shad Thames SE1 2LY London | United Kingdom | British | 94880800002 | |||||
| TAYLOR, Paul | Director | Sidings Court White Rose Way DN4 5NU Doncaster 3 England | United Kingdom | British | 147757950001 | |||||
| TOMLINSON, Roderick Stuart | Director | Skylark Cockshead Lane Two Dales DE4 2FN Matlock Derbyshire | England | British | 98759760001 | |||||
| TRENDELL, William Anthony | Director | Victorian Rendezvous 18 Rectory Close Merrow GU4 7AR Guildford Surrey | England | British | 12317760001 | |||||
| WORRALL, Andrew James | Director | Walnut Lodge The Paddocks Thorpe Lea Gunthorpe NG14 7FG Nottingham | British | 41781000001 | ||||||
| WYNN, Paul David, Non-Exectuive Director | Director | The Tythe Barn 3 Wordsworth Court, Water Hall Lane S36 8EQ Penistone | England | British | 180353010001 | |||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PENNINE WASTE MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derbyshire Waste Limited | 10 feb 2025 | Sidings Court White Rose Way DN4 5NU Doncaster 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Fcc Environment (Uk) Limited | 07 abr 2016 | Sidings Court DN4 5NU Doncaster 3 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0