WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03057565 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| DUELGUIDE WHITE CITY SALP LIMITED | 07 jun 2005 | 07 jun 2005 |
| CHELSFIELD WHITE CITY SALP LIMITED | 14 ene 2003 | 14 ene 2003 |
| SCOTTISH AMICABLE WHITE CITY LP LIMITED | 27 jul 1995 | 27 jul 1995 |
| DOTHAN LIMITED | 17 may 1995 | 17 may 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Resolución de insolvencia Resolution INSOLVENCY:resolution in respect of statement of account final meeting | 1 páginas | LIQ MISC RES | ||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | 4.71 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 6th Floor Midcity Place 71 High Holborn London WC1V 6EA | 2 páginas | AD03 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 6th Floor Midcity Place 71 High Holborn London WC1V 6EA | 2 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 6th Floor Midcity Place 71 High Holborn London WC1V 6EA a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR el 13 jul 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 30 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Simon Slavin como director el 22 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Leon Shelley como director el 22 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Joseph Gutman como director el 22 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Andrew Hodes como director el 12 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 oct 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 30 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael Joseph Gutman el 15 may 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Philip Simon Slavin el 27 sept 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 13 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELLEY, Leon | Secretario | 6th Floor Midcity Place 71 High Holborn WC1V 6EA London | British | 115567560003 | ||||||
| HODES, Jonathan Andrew | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | British | 140632920001 | |||||
| MILLER, Peter Howard | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | Australian | 156391840001 | |||||
| SHELLEY, Leon | Director | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | United Kingdom | British | 115567560003 | |||||
| COOK, Kenneth Alan | Secretario | 27 Glendower Road East Sheen SW14 8NY London | British | 100000003 | ||||||
| HARRISON, Linda Christine | Secretario | 87 Kimberley Road CR0 2PZ Croydon Surrey | British | 85883750001 | ||||||
| MOLLOY, Fiona Jane | Secretario | 64 Old Fold View EN5 4EB Barnet Hertfordshire | British | 75464460002 | ||||||
| RUPAREL, Vanessa Frances | Secretario | 54 Clarendon Avenue CV32 4SA Leamington Spa Warwickshire | British | 66822710002 | ||||||
| RUTHERFORD, Adam Paul | Secretario | 12 Pilgrims Close LU5 6LX Harlington Bedfordshire | British | 70451850001 | ||||||
| CMH SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000940001 | |||||||
| BUTLER, Robin Elliott | Director | Gatehouse Farm Rogate GU31 5DB Petersfield Hampshire | England | British | 2996760007 | |||||
| FERRANS, Douglas | Director | 9 Lochbroom Drive Newton Mearns G77 5DY Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 1166720002 | |||||
| GILCHRIST, Stewart | Director | 25 St Germains Bearsden G61 2RS Glasgow | British | 45170230001 | ||||||
| GUTMAN, Michael Joseph | Director | 6th Floor Midcity Place 71 High Holborn WC1V 6EA London | United Kingdom | Australian | 130479490009 | |||||
| HUGILL, William Nigel | Director | 15 Briar Walk Putney SW15 6UD London | England | British | 3015960006 | |||||
| HUNTER, David Ian | Director | Leewood, Titwood Road Newton Mearns G77 6RP Glasgow | United Kingdom | British | 1151130002 | |||||
| KNOX, William Graeme | Director | The Pepper Pot Station Road Killearn G63 9NZ Glasgow | British | 48559700001 | ||||||
| MACKRILL, Brian James | Director | 6th Floor Midcity Place 71 High Holborn WC1V 6EA London | British | 119228590001 | ||||||
| MOORE, Martin Richard | Director | 3 Ripley Close BR1 2TZ Bickley Kent | United Kingdom | British | 44226390001 | |||||
| NICOLSON, Roy Macdonald | Director | 'Ardgarten' 45 Doune Road FK15 9HR Dunblane Perthshire | British | 238750001 | ||||||
| ROBERTS, Andrew Timothy | Director | 40 Berkeley Square W1J 5AL London | British | 79804060006 | ||||||
| RUSANOW, Elliott | Director | Level 24 Westfield Towers, 100 William Street FOREIGN Sydney Nsw 2011 Australia | Australian/British | 102512610004 | ||||||
| SLAVIN, Philip Simon | Director | 6th Floor Midcity Place 71 High Holborn WC1V 6EA London | United Kingdom | British | 140633010003 | |||||
| THOMPSON, Nicholas Henry Croom | Director | Longwood Orchehill Avenue SL9 8QJ Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 227950002 | |||||
| CMH DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000930001 | |||||||
| CMH SECRETARIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitre House 160 Aldergate Street EC1A 4DD London | 900000940001 |
¿Tiene WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A security deed | Creado el 15 sept 2004 Entregado el 04 oct 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due of each obligor to any mezzanine finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 sept 1995 Entregado el 05 oct 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (acting in their capacity as limited partners in the white city (shepherds bush) limited partnership) to the chargee under the terms of the development agreement, the red land lease the site lease and the debenture (as defined in the deed) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene WESTFIELD WHITE CITY SALP LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0