AUTODIAGNOS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAUTODIAGNOS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03062855
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AUTODIAGNOS LIMITED?

    • (9305) /

    ¿Dónde se encuentra AUTODIAGNOS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Hopton Industrial Estate
    London Road
    SN10 2EU Devizes
    Wiltshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AUTODIAGNOS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AUTODIAGNOS UK LIMITED19 dic 199519 dic 1995
    AUTO DIAGNOSTIC UK LIMITED31 may 199531 may 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AUTODIAGNOS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AUTODIAGNOS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 may 2011

    Estado de capital el 20 may 2011

    • Capital: GBP 674,445
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    6 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    18 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    19 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asistencia financiera para la adquisición de acciones

    RES07

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2006

    8 páginasAA

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2005

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    1 páginas403a

    ¿Quiénes son los directivos de AUTODIAGNOS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COWARD, Jeremy
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    Secretario
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    British108477480002
    COWARD, Jeremy
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    Director
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish108477480002
    HOULDEN, Peter John
    32 Wembdon Hill
    Wembdon
    TA6 7PX Bridgwater
    Somerset
    Director
    32 Wembdon Hill
    Wembdon
    TA6 7PX Bridgwater
    Somerset
    EnglandBritish57753270002
    WATKINS, John Ferris
    The Old Watermill
    Mill Hill Chiddingstone
    TN8 7AA Edenbridge
    Kent
    Director
    The Old Watermill
    Mill Hill Chiddingstone
    TN8 7AA Edenbridge
    Kent
    EnglandBritish117984420001
    DAWSON, Yvette Julie
    10 Meadowbarn Close
    Cottam
    PR4 0AG Preston
    Secretario
    10 Meadowbarn Close
    Cottam
    PR4 0AG Preston
    British43525650001
    ERICSON, Per Anders
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Secretario
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Swedish44535810001
    GRILK, Thomas Swiney
    10 Underhill Road
    Lynnfield
    Ma 01940
    Usa
    Secretario
    10 Underhill Road
    Lynnfield
    Ma 01940
    Usa
    American114994150001
    ISAKSSON, Fredrik
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Secretario
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Swedish52950120001
    JOHNSON, Neil Austin
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Secretario
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    British66481370002
    MARCHENT, Nevelle
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    Secretario
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    British64655230002
    TAFLIN, Lars Ivar
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Secretario
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Swedish44535840002
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secretario corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    73539350001
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Secretario designado corporativo
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    BEECHER, Gregory R
    23 Yale Street
    Winchester
    Ma 01890
    Usa
    Director
    23 Yale Street
    Winchester
    Ma 01890
    Usa
    United StatesAmerican82434140001
    CHAMILLARD, George William
    378 Jerusalem Road
    Cohasset
    Ma 02025
    Usa
    Director
    378 Jerusalem Road
    Cohasset
    Ma 02025
    Usa
    American54708040002
    DAWSON, David Martin
    2 The Grange
    Cottam
    PR4 0LE Preston
    Director
    2 The Grange
    Cottam
    PR4 0LE Preston
    British43525590002
    ERICSON, Per Anders
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Director
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Swedish44535810001
    HUNT, Christopher John
    Brook Cottage
    26 Robert Street
    TA4 4PG Williton
    Somerset
    Director
    Brook Cottage
    26 Robert Street
    TA4 4PG Williton
    Somerset
    British56539710002
    ISAKSSON, Fredrik
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Director
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Swedish52950120001
    JOHNSON, Neil Austin
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Director
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    British66481370002
    KOLOSKA, Walt
    Ketch House Enmore Road
    Enmore
    TA5 2DP Bridgwater
    Somerset
    Director
    Ketch House Enmore Road
    Enmore
    TA5 2DP Bridgwater
    Somerset
    EnglandBritish57917120001
    MARCHENT, Nevelle
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    Director
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    EnglandBritish64655230002
    MILES, Peter Richard
    12 Lumb Lane
    SK7 2BA Bramhall
    Cheshire
    Director
    12 Lumb Lane
    SK7 2BA Bramhall
    Cheshire
    United KingdomBritish70262390003
    OSATTIN, Stuart Mark
    44 Pineclife Drive
    Marblehead
    Ma 01945
    Usa
    Director
    44 Pineclife Drive
    Marblehead
    Ma 01945
    Usa
    American82099560001
    TAFLIN, Lars Ivar
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Director
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Swedish44535840002
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Director designado corporativo
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    ¿Tiene AUTODIAGNOS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    All assets debenture
    Creado el 04 ene 2010
    Entregado el 06 ene 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 06 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 18 dic 2006
    Entregado el 30 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 dic 2006Registro de un cargo (395)
    Guarantee & debenture
    Creado el 16 ene 2006
    Entregado el 27 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creado el 06 nov 2003
    Entregado el 14 nov 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rent deposit sum of £12,102.50.
    Personas con derecho
    • Bruntwood Estates Limited
    Transacciones
    • 14 nov 2003Registro de un cargo (395)
    All assets debenture
    Creado el 22 ago 2003
    Entregado el 30 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0