STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED

STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 03065012
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Commerce House
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2023

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 may 2023

    9 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2023 au 31 may 2023

    1 páginasAA01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022

    9 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Business Innovation Centre Studio 10 Sutherland Institute Lightwood Road Longton Stoke-on-Trent ST3 4HY United Kingdom a Commerce House Etruria Stoke-on-Trent ST1 5BE el 03 ago 2022

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2021

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Kevin Lee Taylor como director el 02 sept 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2020

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jonathan Robert Andrew como director el 18 feb 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Kevin Lee Taylor como director el 06 ago 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2019

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director Rebekah Herschel Shenton el 18 ago 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2018

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Business Innovation Centre Staffordshire Technology Park Beaconside Stafford ST18 0AR a Business Innovation Centre Studio 10 Sutherland Institute Lightwood Road Longton Stoke-on-Trent ST3 4HY el 15 nov 2017

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2017

    10 páginasAA

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 páginasPSC08

    ¿Quiénes son los directivos de STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    K & S SECRETARIES LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle
    The Brampton
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle
    The Brampton
    Staffordshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02795473
    114754200001
    BRIGGS, Andrew
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Director
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish163842990001
    FRANCIS, John Stuart
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Director
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish40524300001
    HARPER, Rebekah Herschel
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Director
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    United KingdomBritish111618580004
    KELSALL, Eric
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Director
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish99415580001
    KELSALL, Rachel Louise
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Director
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    EnglandBritish190000760001
    MORRIS, Paul Jonathan
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Director
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish151623600001
    PEARCE, Anthony Norman, Councellor
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Director
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish65400220002
    RILEY, Geoffrey
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Director
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    EnglandBritish133180130001
    BIRD, James Christopher Michael
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    British63447900002
    MILLER, Derek John
    6 Sidmouth Avenue
    ST5 0QN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secretario
    6 Sidmouth Avenue
    ST5 0QN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British37920530001
    PRICE, Sebastian
    The Hawthorns Cherry Tree Lane
    Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    Secretario
    The Hawthorns Cherry Tree Lane
    Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    British68818870001
    QUIRK, Cindy Ann
    Ardencote
    New Street Lane
    TF9 3RN Market Drayton
    Salop
    Secretario
    Ardencote
    New Street Lane
    TF9 3RN Market Drayton
    Salop
    British46098140002
    K&S DIRECTORS LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Secretario corporativo
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    97199250001
    ANDERSON, Sarah, Dr
    64 Heathend Road
    Alsager
    ST7 2SH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    64 Heathend Road
    Alsager
    ST7 2SH Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish19798790001
    ANDREW, Jonathan Robert
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Director
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    United KingdomBritish64082380001
    ASTON, Ronald
    Fox House Tythe Barn
    Alton
    ST10 4AZ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    Fox House Tythe Barn
    Alton
    ST10 4AZ Stoke On Trent
    Staffordshire
    British43668490001
    BIRD, James Christopher Michael
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    British63447900002
    BLAKE, David
    17 Canalside Close
    ST19 5TX Penkridge
    Staffordshire
    Director
    17 Canalside Close
    ST19 5TX Penkridge
    Staffordshire
    British57941390002
    BODEN, Philip Keeling
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    Director
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    British34859400001
    BOOTH, Sandra
    Margaret Street
    ST15 8EL Stone
    16 Reliant House
    Staffordshire
    Director
    Margaret Street
    ST15 8EL Stone
    16 Reliant House
    Staffordshire
    UkBritish146050960001
    BURNS, Stephen James
    32 Raleigh Close
    Old Hall
    WA5 5QS Warrington
    Cheshire
    Director
    32 Raleigh Close
    Old Hall
    WA5 5QS Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish174030900001
    CLARK, Graham Roger
    5 Horsefair
    Eccleshall
    ST21 6AA Stafford
    Staffordshire
    Director
    5 Horsefair
    Eccleshall
    ST21 6AA Stafford
    Staffordshire
    British57392030001
    COOPER, Alan John, Dr
    146 Stubby Lane
    Wednesfield
    WV11 3NF Wolverhampton
    West Midlands
    Director
    146 Stubby Lane
    Wednesfield
    WV11 3NF Wolverhampton
    West Midlands
    British32145970001
    DAIN, John Stewart
    32 Captains Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EZ Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    32 Captains Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EZ Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish7028540001
    DRYER, John Richard
    College Road
    ST4 2DE Stoke-On-Trent
    Staffordshire University
    Staffordshire
    England
    Director
    College Road
    ST4 2DE Stoke-On-Trent
    Staffordshire University
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish193362300001
    FELTBOWER, Geoffrey Howard
    28 Megacre
    Bignall End
    ST7 8PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    28 Megacre
    Bignall End
    ST7 8PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish57392150002
    GALLAGHER, Rosalind
    Milestone Cottage
    15 Nantwich Road, Woore
    CW3 9SB Crewe
    Cheshire
    Director
    Milestone Cottage
    15 Nantwich Road, Woore
    CW3 9SB Crewe
    Cheshire
    British74980860001
    GRANT, John Victor
    60 Cannock Road
    ST17 0QQ Stafford
    Staffordshire
    Director
    60 Cannock Road
    ST17 0QQ Stafford
    Staffordshire
    British65880600001
    HEERAN, Mark Michael
    Tixall Road
    Littleworth
    ST16 3UY Stafford
    91
    Staffordshire
    Director
    Tixall Road
    Littleworth
    ST16 3UY Stafford
    91
    Staffordshire
    United KingdomBritish147619080001
    HENSON, Ronald Michael, Dr
    11 Weeping Cross
    ST17 0DF Stafford
    Staffordshire
    Director
    11 Weeping Cross
    ST17 0DF Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish10023600001
    JACKSON, Stuart Malcolm
    21 The Brambles
    Westbury Park Clayton
    ST5 4JJ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Director
    21 The Brambles
    Westbury Park Clayton
    ST5 4JJ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    United KingdomBritish79731380001
    LYNCH, David Ross
    The Outlands Bishops Offley
    Eccleshall
    ST21 6HB Stafford
    Staffs
    Director
    The Outlands Bishops Offley
    Eccleshall
    ST21 6HB Stafford
    Staffs
    United KingdomBritish111260170001
    MABEY, Mark, Dr
    2 Leadbeater Avenue
    Penghull
    ST4 5HE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    2 Leadbeater Avenue
    Penghull
    ST4 5HE Stoke On Trent
    Staffordshire
    British115823450001
    MATHER, David
    35 Pack Horse Road
    Melbourne
    DE73 8EG Derby
    Derbyshire
    Director
    35 Pack Horse Road
    Melbourne
    DE73 8EG Derby
    Derbyshire
    British120208940001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 abr 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 26 sept 2002
    Entregado el 17 oct 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 17 oct 2002Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0