GROUNDWORK KENT & MEDWAY

GROUNDWORK KENT & MEDWAY

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGROUNDWORK KENT & MEDWAY
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 03068263
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GROUNDWORK KENT & MEDWAY?

    • Otras actividades de trabajo social sin alojamiento n.c.p. (88990) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra GROUNDWORK KENT & MEDWAY?

    Dirección de la sede social
    The Old Weighbridge
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    Kent
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GROUNDWORK KENT & MEDWAY?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GROUNDWORK MEDWAY SWALE09 jun 199509 jun 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GROUNDWORK KENT & MEDWAY?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GROUNDWORK KENT & MEDWAY?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2013, aucune liste de membres fournie

    3 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Catherine Jane Cribbon como director el 29 may 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Gordon Clark como director el 27 may 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Martin Cubitt como director el 02 may 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Patricia Anne Thurlow como director el 11 abr 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Henry Seymour Simmons como director el 17 abr 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Martin Hicks como director el 17 abr 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David John Simms como director el 23 abr 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Frank William Webb como director el 09 abr 2013

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    22 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2012, aucune liste de membres fournie

    7 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de 48 Canterbury Street Gillingham Kent ME7 5UN el 21 mar 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2011

    22 páginasAA

    Nombramiento de Mr John Martin Cubitt como director el 25 jul 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Scudder como director el 03 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Catherine Jane Cribbon como director el 17 may 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ann Allen como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 jun 2011, aucune liste de membres fournie

    7 páginasAR01

    Cese del nombramiento de John Cubitt como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Raby como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Cllr David Henry Seymour Simmons como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Peter Martin Hicks como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de GROUNDWORK KENT & MEDWAY?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WOODCOCK, Claire
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Secretario
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    147643290001
    HARMAN, Richard John
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Director
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    EnglandBritishPart-Time Planning Consultant61461380002
    HEELEY, Mark
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Director
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    EnglandBritishChartered Surveyor42464550001
    JONES, Anthony
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Director
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    EnglandBritishRetired46359550001
    GREEN, Simon Barcham
    1 Snapgate Cottages
    Staplehurst
    TN12 0HU Tonbridge
    Kent
    Secretario
    1 Snapgate Cottages
    Staplehurst
    TN12 0HU Tonbridge
    Kent
    BritishExecutive Director8035510001
    SCUDDER, David
    2 Recreation Way
    Kemsley
    ME10 2RD Sittingbourne
    Kent
    Secretario
    2 Recreation Way
    Kemsley
    ME10 2RD Sittingbourne
    Kent
    British7525770003
    ALLEN, Ann Dorothy, Cllr
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    Director
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    EnglandBritishNone71446630001
    ALLEN, Raymond Charles
    Kestrels
    Main Road Sellindge
    TN25 6EQ Ashford
    Kent
    Director
    Kestrels
    Main Road Sellindge
    TN25 6EQ Ashford
    Kent
    BritishRetired Councillor44119220002
    ATKINS, Stephen
    Rocks Oast The Rocks Road
    East Malling
    ME19 6AU West Malling
    Kent
    Director
    Rocks Oast The Rocks Road
    East Malling
    ME19 6AU West Malling
    Kent
    BritishChartered Surveyor54295650001
    BARBER, Frank Walter Bradfield
    5 Pegwell Avenue
    Pegwell
    CT11 0NL Ramsgate
    Kent
    Director
    5 Pegwell Avenue
    Pegwell
    CT11 0NL Ramsgate
    Kent
    BritishChartered Surveyor106908330001
    BATES, Antony Lee
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    Director
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    EnglandBritishOperations Manager95842200001
    BAYFORD, Alan William
    Forge House
    The Street
    ME9 0BG Doddington
    Kent
    Director
    Forge House
    The Street
    ME9 0BG Doddington
    Kent
    United KingdomBritishHead Teacher75655170001
    BENNETT, Robert Charles
    Little End Lane Tattlebury Cottage
    Tattlebury
    TN27 9JU Headcorn
    Kent
    Director
    Little End Lane Tattlebury Cottage
    Tattlebury
    TN27 9JU Headcorn
    Kent
    EnglandBritishSurveyor38870540001
    BILLOT, Hugh Edward, Dr
    Randolphs Leap Pluckley Road
    Charing
    TN27 0AG Ashford
    Kent
    Director
    Randolphs Leap Pluckley Road
    Charing
    TN27 0AG Ashford
    Kent
    United KingdomBritishDirector39608830001
    BOWLER, Nicholas Paul
    29 Clive Road
    ME1 3BZ Rochester
    Kent
    Director
    29 Clive Road
    ME1 3BZ Rochester
    Kent
    BritishHead Chef76873260001
    BRANGWIN, Charles William
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    Director
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    EnglandBritishChartered Surveyor137328570001
    BUCKLEY, Bernice Rose, Doctor
    5 Bickmore Way
    TN9 1ND Tonbridge
    Kent
    Director
    5 Bickmore Way
    TN9 1ND Tonbridge
    Kent
    BritishGeneral Manager54138190002
    CHERRY, Alan Herbert
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    Director
    Harvesters Green Street
    Fryerning
    CM4 ONS Ingatestone
    Essex
    EnglandBritishDeveloper2026150001
    CLARK, Paul Gordon
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Director
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    EnglandBritishMp78123640002
    CRIBBON, Catherine Jane
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Director
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    United KingdomIrishNone97944620001
    CUBITT, John Martin
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Director
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    United KingdomBritishCouncillor131238090001
    CUBITT, John Martin
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    Director
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    United KingdomBritishRetired131238090001
    CUNNINGHAM, David John
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    Director
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    EnglandBritishHead Of Quality103148470001
    DAVIES, Crispin
    1 Cherry Gardens
    Littlestone
    TN28 8QR New Romney
    Kent
    Director
    1 Cherry Gardens
    Littlestone
    TN28 8QR New Romney
    Kent
    BritishCharity Chief Officer44119320001
    DAVIS, Cynthia
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    Director
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    EnglandBritishCouncillor134898430001
    DISNEY, John George, Cllr
    The Walnuts
    London Road
    ME9 9QS Lynsted
    Kent
    Director
    The Walnuts
    London Road
    ME9 9QS Lynsted
    Kent
    BritishRetired122133690001
    DRURY, Michael David
    ME9 7DY Lower Halstow
    The Boat House
    Kent
    Director
    ME9 7DY Lower Halstow
    The Boat House
    Kent
    United KingdomBritishSelf Employed Developer186893950001
    EDWARDS DAEM, Peter, Councillor
    Snodhurst Farm
    17 Walderslade Road
    ME5 0LU Chatham
    Kent
    Director
    Snodhurst Farm
    17 Walderslade Road
    ME5 0LU Chatham
    Kent
    BritishHouse Husband64418430001
    FOSTER, Wilhelm Paul
    224 Lonsdale Drive
    Rainham
    ME8 9JN Gillingham
    Kent
    Director
    224 Lonsdale Drive
    Rainham
    ME8 9JN Gillingham
    Kent
    BritishDirector18165450001
    FRANCIS, Troy Nageeb
    135 Manor Way
    ME12 4QZ Leysdown On Sea
    Kent
    Director
    135 Manor Way
    ME12 4QZ Leysdown On Sea
    Kent
    JamaicanNeighborhood Director108874690002
    FRASER, Stuart
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    Director
    48 Canterbury Street
    Gillingham
    ME7 5UN Kent
    EnglandBritishConstruction Director64666020001
    GATES, Thomas, Councillor
    62a Abbey Street
    ME13 7BN Faversham
    Kent
    Director
    62a Abbey Street
    ME13 7BN Faversham
    Kent
    EnglandBritishBuilder Semi Retired152906580001
    HANNANT, Susan Lesley
    10 Belmont Road
    ME7 5JB Gillingham
    Kent
    Director
    10 Belmont Road
    ME7 5JB Gillingham
    Kent
    BritishNone43474960001
    HENDERSON, Michael Scott
    Bridge House
    The Brents
    ME13 7DR Faversham
    Kent
    Director
    Bridge House
    The Brents
    ME13 7DR Faversham
    Kent
    EnglandBritishTraining Company Manager107988110001
    HICKS, Peter Martin
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    Director
    Manor Way
    DA10 0LL Swanscombe
    The Old Weighbridge
    Kent
    England
    United KingdomBritishField Services Manager136111410001

    ¿Tiene GROUNDWORK KENT & MEDWAY alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 08 nov 2001
    Entregado el 15 nov 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a 48 canterbury street gillingham and land on the east side of canterbury street gillingham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 nov 2001Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0