FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03074331
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OMEGA (UK) LIMITED26 jun 199526 jun 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 jul 2015

    Estado de capital el 23 jul 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cambio de datos del director Ian Richard Smith el 19 feb 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Benjamin Robert Taberner el 18 feb 2015

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Dominic Jude Kay como director el 28 oct 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 jul 2014

    Estado de capital el 03 jul 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Dominic Kay como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Abigail Mattison como secretario

    2 páginasAP03

    Cambio de datos del director Maureen Claire Royston el 22 may 2014

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* el 21 feb 2014

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Maureen Claire Royston como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter Calveley como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ian Richard Smith como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 26 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Secretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188573200001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Director
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Director
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Director
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Secretario
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Secretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    CMM (SECRETARIES) LIMITED
    Sceptre House
    169/173 Regent Street
    W1R 7FB London
    Secretario designado corporativo
    Sceptre House
    169/173 Regent Street
    W1R 7FB London
    900004970001
    SCEPTRE CONSULTANTS LIMITED
    6 Babmaes Street
    SW1Y 6HD London
    Secretario corporativo
    6 Babmaes Street
    SW1Y 6HD London
    32627710003
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Director
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    BAILEY, Essel
    900 Victors Way
    Suite 350
    Ann Arbor
    Mi 48108
    Usa
    Director
    900 Victors Way
    Suite 350
    Ann Arbor
    Mi 48108
    Usa
    American55075420002
    BEARDSLEY, Julian Richard
    Flat 2
    27 Moring Road
    SW17 8DN London
    Director
    Flat 2
    27 Moring Road
    SW17 8DN London
    British67039610001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Director
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Director
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    ELLIOTT, Graham Nicholas
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Director
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    EnglandBritish38064300002
    FLAHERTY, James Paul
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    Director
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    American52843400002
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Director
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Director
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Director
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    MAYNARD, Tanya
    14 Bayham Road
    Chiswick
    W4 1BJ London
    Director
    14 Bayham Road
    Chiswick
    W4 1BJ London
    British41493210001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    NOBLE, Edward Charles
    9668 Tree Top Court
    Pickney
    FOREIGN Michigan
    Usa
    Director
    9668 Tree Top Court
    Pickney
    FOREIGN Michigan
    Usa
    American69199980002
    ROBINSON, Todd Philip
    2307 Princess Ann Street
    Greensboro
    North Carolina 27408
    Usa
    Director
    2307 Princess Ann Street
    Greensboro
    North Carolina 27408
    Usa
    American77491610001
    STOREY, John
    17 Collins Street
    SE3 0UG London
    Director
    17 Collins Street
    SE3 0UG London
    British60123860001
    STOVER, David
    905 West Eisenhower Circle
    Suite 110
    48103 Ann Arbor Michigan
    Washtenaw County
    Usa
    Director
    905 West Eisenhower Circle
    Suite 110
    48103 Ann Arbor Michigan
    Washtenaw County
    Usa
    American55075550001
    WILLIS, Graeme
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    British71527500004

    ¿Tiene FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Scottish floating charge
    Creado el 24 nov 2006
    Entregado el 14 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First floating charge all its present and future property,assets and undertaking situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse,London Branch
    Transacciones
    • 14 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 20 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A security deed
    Creado el 30 oct 2006
    Entregado el 17 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse London Branch
    Transacciones
    • 17 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 23 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 ene 2006
    Entregado el 18 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 29 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rhyme debenture
    Creado el 12 nov 2004
    Entregado el 30 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Scarlet Finance Limited
    Transacciones
    • 30 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 27 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A charge over bank accounts
    Creado el 03 jul 2003
    Entregado el 11 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its rights and interests in, and all monies standing to the credit of the account by way of first fixed charge. A floating charge as further security for the payment of the indebtedness, charged with full title guarantee all its rights and interests in, and all monies stnading to the credit of, the account.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed
    Creado el 01 oct 2002
    Entregado el 16 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all freehold and leasehold property together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property; and by way of first equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclay Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 16 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 jun 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0