WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED

WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03074509
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NOSU DEVELOPMENTS LIMITED02 ago 199502 ago 1995
    HACKREMCO (NO. 1058) LIMITED30 jun 199530 jun 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    2 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE el 08 mar 2012

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 feb 2012

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de Nicholas Paul Kelsall como director el 23 ene 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert William Game como director el 23 ene 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Vinod Bachulal Vaghela como director el 03 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Robert William Game como director el 03 nov 2011

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 jul 2011

    Estado de capital el 06 jul 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    10 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    11 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    11 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2006

    13 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Secretario
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GIBSON, Graeme David
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    Director
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish60838970001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Director
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Secretario
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Secretario
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Secretario
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Secretario
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secretario designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Director
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    COULING, Graham Charles
    47 Lime Grove
    Kirby Muxloe
    LE9 2DF Leicester
    Director
    47 Lime Grove
    Kirby Muxloe
    LE9 2DF Leicester
    British41278620002
    EDWARDS, John Nigel
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    Director
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    United KingdomBritish37742270003
    EDWARDS, John Nigel
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    Director
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    British37742270001
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United Kingdom
    Director
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomEnglish139555050001
    GIBSON, Graeme David
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    Director
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish60838970001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    Director
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEWITT, Alan
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    Director
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    British572100002
    JACKSON, Martin
    6 Fern Lea Drive
    SK11 8PQ Macclesfield
    Cheshire
    Director
    6 Fern Lea Drive
    SK11 8PQ Macclesfield
    Cheshire
    British70926010001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Director
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    KELSALL, Nicholas Paul
    7 Dunnockswood
    Alsager
    ST7 2XU Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    7 Dunnockswood
    Alsager
    ST7 2XU Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish34374490002
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    NEVIN, Mark
    110 Westmorland Road
    Urmston
    M41 9HP Manchester
    Director
    110 Westmorland Road
    Urmston
    M41 9HP Manchester
    EnglandBritish72157500001
    OVENS, Mark Douglas
    Birdhurst
    37 The Warren
    SM5 4EQ Carshalton
    Surrey
    Director
    Birdhurst
    37 The Warren
    SM5 4EQ Carshalton
    Surrey
    United KingdomBritish56734030003
    RIX, Timothy
    93 Chertsey Road
    GU20 6HU Windlesham
    Surrey
    Director
    93 Chertsey Road
    GU20 6HU Windlesham
    Surrey
    British47277200001
    ROGERS, Martin John
    Wood Knoll 49 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    Director
    Wood Knoll 49 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish31854560001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Director
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Director
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Director
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Director designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    ¿Tiene WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating charge
    Creado el 21 mar 1996
    Entregado el 27 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any loan document (as defined)
    Breve descripción
    Land at chapel hill braintree essex t/n ex 502805 and part of land within t/n ex 379124. by way of first equitable mortgage all real property acquired by the company after the creation of the charge. Floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Norcross Developments Limited
    Transacciones
    • 27 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating legal charge
    Creado el 21 mar 1996
    Entregado el 26 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any loan document
    Breve descripción
    Land at chapel hill braintree essex t/n EX502805 and part of the land within title number EX379124 and by way of first floating charge all undertaking and assets.
    Personas con derecho
    • Suter Estates Limited
    Transacciones
    • 26 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 17 ago 1995
    Entregado el 01 sept 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 16TH august 1995
    Breve descripción
    F/H property k/a land at chapel hill, braintree t/no. EX502805 and all buildings and fixtures thereon. First equitable mortgage all real property acquired by the company after the creation of the charge. First floating charge on all undertaking and assets of the company present and future including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Suter Estates Limited
    Transacciones
    • 01 sept 1995Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 nov 2012Fecha de disolución
    28 feb 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Profesional
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0