LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03074537 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Kingsway WC2B 6AN London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE INVESTMENTS (UK) LIMITED | 17 nov 1999 | 17 nov 1999 |
| MACQUARIE INVESTMENTS (UK) LIMITED | 10 nov 1999 | 10 nov 1999 |
| KVAERNER INVESTMENTS LIMITED | 02 jul 1997 | 02 jul 1997 |
| BERKELEY STREET (NO.3) LIMITED | 12 dic 1995 | 12 dic 1995 |
| HACKREMCO (NO. 1068) LIMITED | 30 jun 1995 | 30 jun 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carl Harvey Dix como director el 30 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Clare Underwood como director el 30 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Emily Martin como secretario el 30 abr 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Stuart Martin Colvin como director el 30 abr 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Naylor como secretario el 18 ene 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Carl Harvey Dix el 31 mar 2016 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Teresa Sarah Hedges como secretario el 31 oct 2016 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Philip Naylor como secretario el 31 oct 2016 | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Maria Lewis como secretario el 04 sept 2015 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Teresa Sarah Hedges como secretario el 04 sept 2015 | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Emily | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 258560880001 | |||||||
| COLVIN, Stuart Martin, Mr. | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | 255570210001 | |||||
| UNDERWOOD, Clare | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | England | British | 250549100002 | |||||
| HEDGES, Teresa Sarah | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 201641500001 | |||||||
| HODGKISS, Richard John | Secretario | Homespun 17 Evening Hill BR3 5UH Beckenham Kent | British | 67128230001 | ||||||
| LAYCOCK, Rufus | Secretario | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | British | 7584610001 | ||||||
| LEWIS, Maria | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 173024570001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 120645920001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| NAYLOR, Philip | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 218721140001 | |||||||
| SHELL, Peter Geoffrey | Secretario | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
| BALLSDON, Andrew James | Director | 10 Fernbrook Road Caversham RG4 7HG Reading Berkshire | England | British | 94560360001 | |||||
| BARRAS, Florence Marie Francoise | Director | 14 Rydon Street N1 7AL London | England | British,French | 58686720001 | |||||
| BAYBUTT, Michael | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | 74962840001 | |||||
| BAYBUTT, Michael | Director | 33 Curtis Wood Park Road CT6 7TY Herne Bay Kent | United Kingdom | British | 74962840001 | |||||
| DIX, Carl Harvey | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | 219588050001 | |||||
| DYER, Peter, Dr | Director | 14 Crofton Avenue Chiswick W4 3EW London | Uk | British | 86711820001 | |||||
| FARRELL, Garry Andrew | Director | 32 Arkwright Road Hampstead NW3 6BH London | Australian | 47007750003 | ||||||
| FINNE, Hans Petter | Director | 32 Gloucester Walk W8 4HY London | Norwegian | 50130950001 | ||||||
| FLETCHER, John Wilfred Sword | Director | House B 36 Island Road Deepwater Bay Hong Kong Sar Pr China | British | 69869500001 | ||||||
| FOWLER, Ian | Director | 32 Newton Road W2 5LT London | British | 41294100001 | ||||||
| FRIEND, Andrew Erskine | Director | 1 Priory Crescent BN7 1HP Lewes East Sussex | England | British | 66359650001 | |||||
| HEGGELUND, Jan Magne | Director | 126 Silverdale Avenue KT12 1EH Walton On Thames Surrey | British | 67742180002 | ||||||
| JAMES, Nicholas Peter | Director | Woodland Cottage Footpath 103 Stone Hill Road Chobham GU24 8HP Woking Surrey | Australian | 67176960001 | ||||||
| LAYCOCK, Rufus | Director | Burghley Avenue KT3 4SW New Malden 33 Surrey | United Kingdom | British | 7584610001 | |||||
| LUCAS, Gary Stephen | Director | 18 Willoughby Way Piddington NN7 2EH Northamptonshire | England | British | 70621740001 | |||||
| MACKIE, Robert Stuart | Director | 21 Graemesdyke Avenue SW14 7BH London | British | 66277230001 | ||||||
| MCLUSKIE, William Grindlay | Director | 17 Pinfield Drive Barnt Green B45 8XA Birmingham West Midlands | British | 25437700001 | ||||||
| MERCER-DEADMAN, Michael John | Director | 18 Tennyson Road AL5 4BB Harpenden Hertfordshire | Uk | British | 10697910001 | |||||
| ROBERTS, John Stuart Hugh | Director | Flat 3 186-190 Bishopsgate EC2M 4NR London | New Zealand | 86873770001 | ||||||
| ROPER, Anthony Charles | Director | Allington Grange Allington SN14 6LW Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 62976440004 | |||||
| SLATER, Michael John | Director | Silver Birch Stone House Lane Cookham Dean SL6 9TP Maidenhead Berkshire | British | 55023780001 | ||||||
| WESTON, Richard | Director | 5 Brackendale Grove Harpenden AL5 3EL St Albans Herts | British | 48554340001 | ||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Laing Social Infrastructure Limited | 06 abr 2016 | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LAING INVESTMENTS GREENWICH LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Shares pledge | Creado el 25 sept 1997 Entregado el 14 oct 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities of the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the senior facility agreement and under each other senior finance document, the junior facility agreement and under any other junior finance document and under any deed or document supplemental thereto | |
Breve descripción 20 fully paid "c" ordinary shares of £1 each and 75,000 preferred ordinary shares of £1 each in the capital of the borrower, all securities and other monies (see schedules attached to form M395 for fulldetails). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0