REX JOHNSON ONLINE LIMITED

REX JOHNSON ONLINE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREX JOHNSON ONLINE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03078447
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?

    • Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra REX JOHNSON ONLINE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit 1 Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CASH-A-CHEQUE (GB) LIMITED08 sept 199508 sept 1995
    WORDPOINT LIMITED11 jul 199511 jul 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REX JOHNSON ONLINE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2019 au 31 may 2019

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Alpesh Kumar Patel como director el 07 oct 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Sheraz Afzal como director el 07 oct 2019

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Kevin Richard Kaye como director el 22 mar 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Alpesh Kumar Patel como director el 22 mar 2019

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Tony Deakin como director el 01 dic 2018

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England a Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN el 12 sept 2018

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Lorna Biondi como secretario el 30 abr 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Tony Deakin como director el 27 feb 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Scott Aaron Cohen como director el 27 feb 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA England a C/O Browne Jacobson Llp Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ

    1 páginasAD02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 6 Bevis Marks London EC3A 7BA a Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ el 16 sept 2016

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Eric George Erickson como director el 08 jul 2016

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AFZAL, Sheraz
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Director
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    United KingdomBritish251073350001
    BIONDI, Lorna
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Secretario
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    196294160001
    FREEMAN, Lynne Ann
    Lakeside Litchborough Road
    Duncote
    NN12 8AL Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    Lakeside Litchborough Road
    Duncote
    NN12 8AL Towcester
    Northamptonshire
    British52719170001
    MCKENZIE, Robbie
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    195401170001
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secretario
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    178139140001
    SALKELD, Ian
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    Secretario
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    British52338990001
    SOKOLOWSKI, Peter John
    208 Rively Avenue
    Collingdale
    Pennsylvannia 19023
    Usa
    Secretario
    208 Rively Avenue
    Collingdale
    Pennsylvannia 19023
    Usa
    American68054300001
    WALTON, Caroline Debra
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Secretario
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    British58608750003
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Secretario designado corporativo
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    TABSEC LIMITED
    Torrington House 47 Holywell Hill
    AL1 1HD St Albans
    Hertfordshire
    Secretario corporativo
    Torrington House 47 Holywell Hill
    AL1 1HD St Albans
    Hertfordshire
    1677520001
    COHEN, Scott Aaron
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Director
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    United StatesAmerican209567180001
    COOK, Richard Charles
    The Cottage 8 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director
    The Cottage 8 Station Road
    Ivinghoe
    LU7 9EB Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British25254880001
    CORNWELL, Nicholas Grant
    The Old Rectory
    Rectory Hill, Cranford St Andrews
    NN14 1HP Kettering
    Northants
    Director
    The Old Rectory
    Rectory Hill, Cranford St Andrews
    NN14 1HP Kettering
    Northants
    United KingdomBritish95585590001
    DEAKIN, Tony
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Director
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    United KingdomBritish210862440001
    DORFMAN, Richard Seth
    9 Pleasant Court
    Medford
    FOREIGN Newjersey 08055
    Usa
    Director
    9 Pleasant Court
    Medford
    FOREIGN Newjersey 08055
    Usa
    American67599880001
    ERICKSON, Eric George
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Director
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaUsa224104020001
    GAYHARDT, Donald Francis
    511 Lynmere Road
    Brynmawr
    FOREIGN Pennsylvannia 19010
    Usa
    Director
    511 Lynmere Road
    Brynmawr
    FOREIGN Pennsylvannia 19010
    Usa
    United StatesAmerican67600210001
    HETHERINGTON, Cameron John
    3 Barculdie Crescent
    QLD 4508 Deception Bay
    Queensland
    Australia
    Director
    3 Barculdie Crescent
    QLD 4508 Deception Bay
    Queensland
    Australia
    Australian123428110001
    HIBBERD, Roy Wayne
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Director
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    UsaUnited States158609380001
    KAYE, Kevin Richard
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Director
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish257480610001
    MAY, Paul Edward
    The Old Rectory
    Bradden
    NN12 8ED Towcester
    Northamptonshire
    Director
    The Old Rectory
    Bradden
    NN12 8ED Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish83046570001
    MCLURE, Gordon Stuart Douglas
    "The Bails" Boughton Hall
    Boughton
    NN2 8SQ Northampton
    Director
    "The Bails" Boughton Hall
    Boughton
    NN2 8SQ Northampton
    British39434610002
    MILDENSTEIN, Paul
    The Barn Redhouse Farm
    Redhouse Farm Lane
    CV35 7NZ Beausale
    2
    Warwickshire
    Director
    The Barn Redhouse Farm
    Redhouse Farm Lane
    CV35 7NZ Beausale
    2
    Warwickshire
    EnglandBritish158561370001
    NORRIS, Terence John
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    Director
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish8778080001
    PATEL, Alpesh Kumar
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Director
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    EnglandBritish193008350001
    PICCINI, Silvio Dante
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Director
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandAmerican129300540002
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Director
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaAmerican177845480001
    SALKELD, Ian
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    Director
    30 Felstead Road
    Wanstead
    E11 2QJ London
    British52338990001
    WEISS, Jeffrey Allan
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    Director
    Lancaster Avenue
    Suite 300
    19312 Berwyn
    1436
    Usa
    UsaUnited States151303310006
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Director designado corporativo
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cash A Cheque Holdings Great Britain Limited
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6 Bevis Marks
    England
    06 abr 2016
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6 Bevis Marks
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalEnglish Law
    Lugar de registroRegister Of Uk Companies, Companies House
    Número de registro03449905
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene REX JOHNSON ONLINE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of deposit
    Creado el 30 oct 2002
    Entregado el 04 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 8706638 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creado el 07 abr 2000
    Entregado el 13 abr 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease of even date
    Breve descripción
    All interest in the rent deposit and the account into which the rent is paid and all money from time to time withdrawn.
    Personas con derecho
    • Imperial Cancer Research Fund
    Transacciones
    • 13 abr 2000Registro de un cargo (395)
    Charge over credit balances
    Creado el 22 feb 2000
    Entregado el 03 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a loan note instrument constituting £1,000,000 guaranteed loan notes 2007 dated 22 february 2000 in favour of cash-a-cheque (GB) limited
    Breve descripción
    The sum of £1,000,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8706638 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge and security agreement
    Creado el 15 sept 1999
    Entregado el 30 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment and performance of its obligations due or to become due from the company to the chargee under the guaranty and guarantor security agreement
    Breve descripción
    All shares in the company all voting and non-voting rights of shares and all cash and non-cash dividends and all other property chattels contracts intangible goods of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Bank National Association, as Administrative Agent for Itself and the Lenders (Asdefined)
    Transacciones
    • 30 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 05 mar 1997
    Entregado el 12 mar 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 mar 1997Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0