REX JOHNSON ONLINE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | REX JOHNSON ONLINE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03078447 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Unit 1 Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CASH-A-CHEQUE (GB) LIMITED | 08 sept 1995 | 08 sept 1995 |
| WORDPOINT LIMITED | 11 jul 1995 | 11 jul 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Declaración de confirmación presentada el 10 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2019 au 31 may 2019 | 1 páginas | AA01 | ||
Cese del nombramiento de Alpesh Kumar Patel como director el 07 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Sheraz Afzal como director el 07 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kevin Richard Kaye como director el 22 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Alpesh Kumar Patel como director el 22 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018 | 7 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Tony Deakin como director el 01 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England a Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN el 12 sept 2018 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Lorna Biondi como secretario el 30 abr 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017 | 7 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Tony Deakin como director el 27 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Scott Aaron Cohen como director el 27 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA England a C/O Browne Jacobson Llp Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ | 1 páginas | AD02 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016 | 7 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de 6 Bevis Marks London EC3A 7BA a Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ el 16 sept 2016 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Eric George Erickson como director el 08 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFZAL, Sheraz | Director | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | United Kingdom | British | 251073350001 | |||||
| BIONDI, Lorna | Secretario | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | 196294160001 | |||||||
| FREEMAN, Lynne Ann | Secretario | Lakeside Litchborough Road Duncote NN12 8AL Towcester Northamptonshire | British | 52719170001 | ||||||
| MCKENZIE, Robbie | Secretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195401170001 | |||||||
| PRIOR, Mark Lee | Secretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178139140001 | |||||||
| SALKELD, Ian | Secretario | 30 Felstead Road Wanstead E11 2QJ London | British | 52338990001 | ||||||
| SOKOLOWSKI, Peter John | Secretario | 208 Rively Avenue Collingdale Pennsylvannia 19023 Usa | American | 68054300001 | ||||||
| WALTON, Caroline Debra | Secretario | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 58608750003 | ||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| TABSEC LIMITED | Secretario corporativo | Torrington House 47 Holywell Hill AL1 1HD St Albans Hertfordshire | 1677520001 | |||||||
| COHEN, Scott Aaron | Director | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | United States | American | 209567180001 | |||||
| COOK, Richard Charles | Director | The Cottage 8 Station Road Ivinghoe LU7 9EB Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 25254880001 | ||||||
| CORNWELL, Nicholas Grant | Director | The Old Rectory Rectory Hill, Cranford St Andrews NN14 1HP Kettering Northants | United Kingdom | British | 95585590001 | |||||
| DEAKIN, Tony | Director | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | United Kingdom | British | 210862440001 | |||||
| DORFMAN, Richard Seth | Director | 9 Pleasant Court Medford FOREIGN Newjersey 08055 Usa | American | 67599880001 | ||||||
| ERICKSON, Eric George | Director | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | Usa | 224104020001 | |||||
| GAYHARDT, Donald Francis | Director | 511 Lynmere Road Brynmawr FOREIGN Pennsylvannia 19010 Usa | United States | American | 67600210001 | |||||
| HETHERINGTON, Cameron John | Director | 3 Barculdie Crescent QLD 4508 Deception Bay Queensland Australia | Australian | 123428110001 | ||||||
| HIBBERD, Roy Wayne | Director | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | Usa | United States | 158609380001 | |||||
| KAYE, Kevin Richard | Director | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 257480610001 | |||||
| MAY, Paul Edward | Director | The Old Rectory Bradden NN12 8ED Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 83046570001 | |||||
| MCLURE, Gordon Stuart Douglas | Director | "The Bails" Boughton Hall Boughton NN2 8SQ Northampton | British | 39434610002 | ||||||
| MILDENSTEIN, Paul | Director | The Barn Redhouse Farm Redhouse Farm Lane CV35 7NZ Beausale 2 Warwickshire | England | British | 158561370001 | |||||
| NORRIS, Terence John | Director | Woodlands Dukes Covert GU19 5HU Bagshot Surrey | United Kingdom | British | 8778080001 | |||||
| PATEL, Alpesh Kumar | Director | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 193008350001 | |||||
| PICCINI, Silvio Dante | Director | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | American | 129300540002 | |||||
| PRIOR, Mark Lee | Director | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | American | 177845480001 | |||||
| SALKELD, Ian | Director | 30 Felstead Road Wanstead E11 2QJ London | British | 52338990001 | ||||||
| WEISS, Jeffrey Allan | Director | Lancaster Avenue Suite 300 19312 Berwyn 1436 Usa | Usa | United States | 151303310006 | |||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash A Cheque Holdings Great Britain Limited | 06 abr 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 Bevis Marks England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene REX JOHNSON ONLINE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit | Creado el 30 oct 2002 Entregado el 04 nov 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All deposits now and in the future credited to account designation 8706638 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rental deposit deed | Creado el 07 abr 2000 Entregado el 13 abr 2000 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease of even date | |
Breve descripción All interest in the rent deposit and the account into which the rent is paid and all money from time to time withdrawn. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over credit balances | Creado el 22 feb 2000 Entregado el 03 mar 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a loan note instrument constituting £1,000,000 guaranteed loan notes 2007 dated 22 february 2000 in favour of cash-a-cheque (GB) limited | |
Breve descripción The sum of £1,000,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8706638 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Pledge and security agreement | Creado el 15 sept 1999 Entregado el 30 sept 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The payment and performance of its obligations due or to become due from the company to the chargee under the guaranty and guarantor security agreement | |
Breve descripción All shares in the company all voting and non-voting rights of shares and all cash and non-cash dividends and all other property chattels contracts intangible goods of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 05 mar 1997 Entregado el 12 mar 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0