THARLMAN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHARLMAN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03081922
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THARLMAN LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra THARLMAN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Cowper Road
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THARLMAN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RUSSELL ARMER HOLDINGS LIMITED18 jul 199618 jul 1996
    MARPLACE (NUMBER 363) LIMITED20 jul 199520 jul 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THARLMAN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THARLMAN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Katie Gordon como secretario el 01 abr 2022

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Bernadette Warburton como secretario el 31 mar 2022

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Bernadette Warburton como secretario el 28 feb 2022

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Joe Abernethy como secretario el 11 feb 2022

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Mintsfeet Place Mintsfeet Road North Kendal Cumbria LA9 6LL a 4 Cowper Road Gilwilly Industrial Estate Penrith CA11 9BN el 05 nov 2021

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Andrew Christopher Taylor como director el 07 abr 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Martyn Nicholson como director el 07 abr 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Karen Patricia Cowgill como secretario el 07 abr 2021

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Joe Abernethy como secretario el 07 abr 2021

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Mark Walker como director el 07 abr 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Nicky James Gordon como director el 07 abr 2021

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 3

    7 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de THARLMAN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GORDON, Katie
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    Secretario
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    294775580001
    GORDON, Nicky James
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    Director
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    EnglandBritishDirector125607140005
    WALKER, Mark
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    Director
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    EnglandBritishDirector71359880006
    ABERNETHY, Joe
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    Secretario
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    281833910001
    BENSON, Colin
    Plough Farm
    Selside
    LA8 9JY Kendal
    Cumbria
    Secretario
    Plough Farm
    Selside
    LA8 9JY Kendal
    Cumbria
    BritishDirector78961300001
    BRANDWOOD, Christopher Mark
    Brook House 77 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    Secretario
    Brook House 77 Fountain Street
    M2 2EE Manchester
    British813160001
    COWGILL, Karen Patricia
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Cumbria
    Secretario
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Cumbria
    British104661840001
    WARBURTON, Bernadette
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    Secretario
    Gilwilly Industrial Estate
    CA11 9BN Penrith
    4 Cowper Road
    England
    293170870001
    DWF SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    C/O Dwf Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3AA Manchester
    Secretario corporativo
    C/O Dwf Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3AA Manchester
    98868640001
    BENSON, Colin
    Plough Farm
    Selside
    LA8 9JY Kendal
    Cumbria
    Director
    Plough Farm
    Selside
    LA8 9JY Kendal
    Cumbria
    EnglandBritishDirector78961300001
    FITZGERALD, David Sean
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    Director
    1 Greenmount Gardens
    Greenmount
    BL8 4HN Bury
    Lancashire
    BritishSolicitor61196400001
    NICHOLSON, David Martyn
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Cumbria
    Director
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Cumbria
    United KingdomBritishQuantity Surveyor3031610001
    TAYLOR, Andrew Christopher
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Cumbria
    Director
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Cumbria
    United KingdomBritishDirector48007650007

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THARLMAN LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Russell Armer Group Limited
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Mintsfeet Place
    Cumbria
    England
    06 abr 2016
    Mintsfeet Place
    Mintsfeet Road North
    LA9 6LL Kendal
    Mintsfeet Place
    Cumbria
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro5363066
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene THARLMAN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment of life policy
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 08 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All sums assured and all bonuses. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Colin Benson
    Transacciones
    • 08 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 29 ene 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment of life policy
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 08 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All sums assured and all bonuses. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Carole Margaret Nicholson
    Transacciones
    • 08 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 08 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All sums assured and all bonuses. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew Christopher Taylor
    Transacciones
    • 08 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 24 ago 1998
    Entregado el 28 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 26 abr 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 04 feb 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 19 ago 1998
    Entregado el 24 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 86 highgate kendal cumbria t/n-CU102174.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 27 mar 1997
    Entregado el 04 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    86 highgate kendal cumbria t/no CU102174.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 12 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0