HAMMOND BRIDGE LIMITED

HAMMOND BRIDGE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHAMMOND BRIDGE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03082707
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HAMMOND BRIDGE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HAMMOND BRIDGE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    142b Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    Oxon
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HAMMOND BRIDGE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PROUDLOCAL LIMITED21 jul 199521 jul 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HAMMOND BRIDGE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 nov 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HAMMOND BRIDGE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2020

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2019

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Monique Louis como director el 01 oct 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Monique Louis como director el 01 oct 2019

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de 140 Eastern Avenue Milton Park, Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SB England a 142B Park Drive Milton Park Abingdon Oxon OX14 4SE el 04 oct 2019

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Mark Jozsef Lagler como director el 01 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gregory Davidson-Shrine como director el 01 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gregory Davidson-Shrine como secretario el 01 oct 2019

    1 páginasTM02

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 06 sept 2019

    • Capital: GBP 1
    14 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2018

    17 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Restated facility agreement and related documents / company business 05/07/2019
    RES13

    Cese del nombramiento de Andrew Wilson como director el 31 may 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 12 dic 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Adrian Crookes como director el 30 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Craig Lewendon como director el 12 sept 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Adrian Crookes como director el 12 sept 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 nov 2017

    18 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de HAMMOND BRIDGE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LAGLER, Mark Jozsef
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    Director
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    United KingdomBritish227904200001
    MARTIN, Neil Thomas George
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    Director
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    United KingdomBritish126681070006
    DAVIDSON-SHRINE, Gregory
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Secretario
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    234770870001
    ELSEY, Robert David
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    Secretario
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    British44433580001
    GAHAN, Michael William
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    Secretario
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    British182707860001
    JARRETT, Susan Lynne
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    Secretario
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    British54448350001
    MARRINER, Stuart Steven
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Secretario
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    168621380001
    STAFFORD, Robert Simeon
    4 Clifton Wood Crescent
    Clifton Wood
    BS8 4TU Bristol
    Secretario
    4 Clifton Wood Crescent
    Clifton Wood
    BS8 4TU Bristol
    British77214360002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNETT, Mark William
    Old Meadows Farm
    Fowlswick Lane, Allington
    SN14 6LT Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Old Meadows Farm
    Fowlswick Lane, Allington
    SN14 6LT Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish78407520002
    BAUERNFEIND, David Gregory
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    Director
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    United KingdomBritish99529910002
    BUNTING, Jonathan Michael
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Director
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish115232260002
    CADDELL, Joseph
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Director
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish115479170002
    CASHMORE, Mark Richard
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Director
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish115657470004
    COOK, Kevin Nigel
    4 Sandcroft Avenue
    BS23 4SS Weston Super Mare
    North Somerset
    Director
    4 Sandcroft Avenue
    BS23 4SS Weston Super Mare
    North Somerset
    British86627710001
    CROOKES, Adrian
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Director
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish174571650001
    DAVIDSON-SHRINE, Gregory
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Director
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish169072790002
    DIBBEN, Kenneth Francis
    Naish Priory
    East Coker
    BA22 9HQ Yeovil
    Somerset
    Director
    Naish Priory
    East Coker
    BA22 9HQ Yeovil
    Somerset
    British14097180001
    DIXON, Nigel Anthony
    Manor Farm House
    SP4 0JZ Porton
    Wiltshire
    Director
    Manor Farm House
    SP4 0JZ Porton
    Wiltshire
    EnglandBritish92047990001
    ELSEY, Robert David
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    Director
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish44433580001
    ELSEY, Robert David
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    Director
    7 Ravenscroft Gardens
    BA14 7JU Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish44433580001
    GAHAN, Michael William
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    Director
    The Orchard
    Vinegar Hill
    NP26 3EJ Undy
    Gwent
    United KingdomBritish182707860001
    GAYLER, David Richard
    Grey Gables
    GL7 4HD Kempsford
    Gloucestershire
    Director
    Grey Gables
    GL7 4HD Kempsford
    Gloucestershire
    British4759540001
    GEORGE, Dudley Robert Charles
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    Director
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    British44433600001
    GEORGE, Dudley Robert Charles
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    Director
    School Cottage
    Coaley
    GL11 5ED Dursley
    Gloucestershire
    British44433600001
    GOULD, Jeffrey Richard
    4 Hobbs Hill
    Keevil
    BA14 6LR Trowbridge
    Wiltshire
    Director
    4 Hobbs Hill
    Keevil
    BA14 6LR Trowbridge
    Wiltshire
    British45469620001
    GRESHAM, Nicholas John
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    Director
    Cherry Orchard North
    Kembrey Park
    SN2 8UH Swindon
    Rowan House
    United Kingdom
    United KingdomBritish91773790002
    JARRETT, Susan Lynne
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    Director
    37 Bobbin Lane
    Westwood
    BA15 2DL Bradford On Avon
    Wiltshire
    British54448350001
    KERSHAW, John Graham Christopher
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Director
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish165578560001
    LAMMING, Richard, Professor
    26 Bath Road
    Beckington
    BA11 6SL Frome
    Director
    26 Bath Road
    Beckington
    BA11 6SL Frome
    United KingdomBritish46380760002
    LEECH, Glenn Peter
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Director
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish131999190002
    LEWENDON, Craig Stuart
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    Director
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritish234768920001
    LOUIS, Monique
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    Director
    Park Drive
    Milton Park
    OX14 4SE Abingdon
    142b
    Oxon
    England
    EnglandBritish238289490001
    PALMER, Matthew James
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    Director
    Pipers Way
    SN3 1RF Swindon
    Wakefield House
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish149814290001
    POTTER, Brian Geoffrey
    Cote Bank
    65a Bristol Road Lower
    BS23 2TL Weston Super Mare
    Somerset
    Director
    Cote Bank
    65a Bristol Road Lower
    BS23 2TL Weston Super Mare
    Somerset
    British72749380002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HAMMOND BRIDGE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hedgelane Limited
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    England
    06 abr 2016
    Eastern Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SB Abingdon
    140
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro06470133
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HAMMOND BRIDGE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 16 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings on the south west side of hammond way trowbridge t/n WT85869. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 nov 2004
    Entregado el 16 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 may 2002
    Entregado el 28 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 28 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 24 ago 1998
    Entregado el 28 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold land/blds on south west side of hammond way trowbridge wiltshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 nov 1995
    Entregado el 09 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 09 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 03 nov 1995
    Entregado el 07 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wiltshire County Council and Others
    Transacciones
    • 07 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0