EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03087337 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Deluxe Limited Film House 142 Wardour Street London W1F 8DD England a Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH el 29 ene 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Deluxe House Unit 32, Perivale Business Park Perivale UB6 7RH | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Eric Cummins como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 3 páginas | MA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 jun 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Cessation de Ronald Owen Perelman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 nov 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Michael Bell como director el 18 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ralph Abraham Levy como director el 18 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sirmad Balal Shafique como director el 18 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Stefanie Liquori Digrigoli como director el 17 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Stuart Howl como director el 07 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ralph Abraham Levy como director el 07 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Sirmad Balal Shafique como director el 07 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew Michael Bell como director el 07 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUORI DIGRIGOLI, Stefanie | Director | Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale Deluxe House England | United States | American | 262502870001 | |||||||||
| ABBOTT, Norman Charles Bettsworth | Secretario | 36 The Street Brooke NR15 1JT Norwich Norfolk | British | 16936560001 | ||||||||||
| ARIAS, Jesus Araujo | Secretario | Ferme Park Road N8 9BL London 260b | Spanish | 128431150001 | ||||||||||
| CATTERALL, Christopher Edward | Secretario | North Orbitial Road Denham UB9 5HQ Uxbridge Denham Media Park Middlesex | British | 156461510001 | ||||||||||
| CLEARY, David James | Secretario | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | 217477240001 | |||||||||||
| HIGHAM, Jennifer | Secretario | 216 Durrant Court CM1 1UE Chelmsford Essex | British | 66973550003 | ||||||||||
| HIGHAM, Jennifer | Secretario | 9 Cassons Close Weston Hills PE12 6DX Spalding Lincolnshire | British | 45596350001 | ||||||||||
| LEWIS, Jonathan Mark | Secretario | 3d Gatesborough Street EC2A 4NS London | British | 75832150002 | ||||||||||
| WATSON, James Neil | Secretario | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | 194237810001 | |||||||||||
| ARCH ACCOUNTANCY | Secretario corporativo | Tesla Court, Innovation Way Lynch Wood PE2 6FL Peterborough 26 United Kingdom |
| 108456720002 | ||||||||||
| ARIAS, Jesus Araujo | Director | Ferme Park Road N8 9BL London 260b | United Kingdom | Spanish | 128431150001 | |||||||||
| BELL, Andrew Michael | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 117165060003 | |||||||||
| CHAO, Gewe | Director | 1040 Shoreland Drive Lopez Island Washington 98261 Usa | Us | 118256440001 | ||||||||||
| COOPER, Alethia | Director | 13669 Legacy Circle \ B Herndon 20171 Usa | Usa | 118330750001 | ||||||||||
| CUMMINS, John Eric | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 246542580001 | |||||||||
| CUPPLES, Amanda Suzanne | Director | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | England | Australian,British | 187272820001 | |||||||||
| DAVIDSON, Neil Patrick | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | Usa | American | 197003660001 | |||||||||
| DONALDSON, Charles Mcbeath | Director | 21 Grimsbury Drive OX16 7HL Banbury Oxfordshire | British | 45216040002 | ||||||||||
| FEINBERG, Jay Mark | Director | 18125 Darnell Dr Olney Naryland 20832 Usa | Usa | 118330590001 | ||||||||||
| GATES, John Lybrook | Director | 405 Southwest Drive Swilver Spring Maryland 20901 Usa | Us Citizen | 74873620001 | ||||||||||
| GEORGAKOPOULOU, Panayota | Director | 137-144 High Holborn WC1V 6PL London Ect 1st Floor Holborn Tower | Greece | Greek | 102661640002 | |||||||||
| GURNEY, Patrick Philip | Director | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | England | British | 216332150001 | |||||||||
| HOWL, Roger Stuart | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 199288360001 | |||||||||
| JONES, John Allan | Director | Hengae Llanllwni SA39 9EE Pencader Dyfed | Welsh | 44176840001 | ||||||||||
| JULIAN, Robert Keith | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 238211530001 | |||||||||
| LEVY, Ralph Abraham | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 253310550001 | |||||||||
| LEWIS, Jonathan Mark | Director | 3d Gatesborough Street EC2A 4NS London | British | 75832150002 | ||||||||||
| MAURER, Tim Charles | Director | North Orbitial Road Denham UB9 5HQ Uxbridge Denham Media Park Middlesex | Usa | American | 157996630001 | |||||||||
| MORLEY, Alexander William John | Director | North Orbitial Road Denham UB9 5HQ Uxbridge Denham Media Park Middlesex | England | British | 156461600001 | |||||||||
| MORLEY, Alexander William John | Director | 164 Windmill Road W5 4BT Ealing London | England | British | 156461600001 | |||||||||
| SEIDEL, Robert T | Director | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | Usa | American | 102781690001 | |||||||||
| SHAFIQUE, Sirmad Balal | Director | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United Kingdom | British | 157242840001 | |||||||||
| SUH, John | Director | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | Usa | American | 173390760001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Ronald Owen Perelman | 06 abr 2016 | 35 East 62nd Street NY 10065 New York Macandrews And Forbes Usa | Sí |
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 06 nov 2019 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Rent security deposit deed | Creado el 03 sept 2009 Entregado el 16 sept 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £33,781.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción The sum of £33,781 and all other monies see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 ene 2007 Entregado el 18 ene 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent security deposit | Creado el 04 ago 2004 Entregado el 14 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The sum of £33,781.25 pursuant to the rent security deposit deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent security dfeposit deed | Creado el 08 may 1998 Entregado el 13 may 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £5,875.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción £5,875.00 (the deposit). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 23 nov 1995 Entregado el 28 nov 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0