EMPRISE PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEMPRISE PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 03089450
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EMPRISE PLC?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra EMPRISE PLC?

    Dirección de la sede social
    Gateway House Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMPRISE PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    EMPRISE LIMITED02 may 200702 may 2007
    EMPRISE PLC21 oct 200421 oct 2004
    EMPRISE LIMITED02 nov 199502 nov 1995
    INGLEBY (835) LIMITED09 ago 199509 ago 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EMPRISE PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 jun 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMPRISE PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    3 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 jul 2019

    31 páginasLIQ03

    Declaración de asuntos

    8 páginasLIQ02

    Domicilio social registrado cambiado de Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG a Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG el 17 jul 2018

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de 186 City Road London EC1V 2NT a Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG el 17 jul 2018

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited como secretario el 16 jul 2018

    1 páginasTM02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 27 jun 2018

    LRESEX

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Exercice comptable en cours prolongé du 29 jun 2017 au 29 dic 2017

    1 páginasAA01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Nombramiento de Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited como secretario el 01 sept 2017

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Mark Ronald Sydney Beadle como secretario el 01 sept 2017

    1 páginasTM02

    Cancelación total de la carga 030894500005

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 jun 2016

    19 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2016 au 29 jun 2016

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Mark Ronald Sydney Beadle como director el 01 abr 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mark Ronald Sydney Beadle como secretario el 01 abr 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Howard Graham Sharp como secretario el 01 abr 2016

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 05 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Howard Graham Sharp como director el 01 abr 2016

    1 páginasTM01

    Comptes annuels modifiés établis au 30 jun 2015

    12 páginasAAMD

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    12 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Howard Graham Sharp el 03 ago 2015

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de EMPRISE PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARRETT, Stephen John
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    Director
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director5149580003
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    Director
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant198215750001
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Secretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    214739420001
    BURROWS, Alison Jane
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Secretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    British166193310001
    CROWFOOT, Martyn Christopher
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Secretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    BritishDirector85033580002
    SHARP, Howard Graham
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Secretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    187487590001
    SHARP, Howard Graham
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secretario
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    British38254450003
    ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    Secretario corporativo
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC131085
    665080009
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Secretario designado corporativo
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    BARRETT, Stephen John
    Amberley
    Lee's Hill
    RG29 1RQ South Warnborough
    Hampshire
    Director
    Amberley
    Lee's Hill
    RG29 1RQ South Warnborough
    Hampshire
    BritishDirector5149580002
    BENCE, Trevor William
    4 Chawkmare Coppice
    Aldwick
    PO21 3BT Bognor Regis
    West Sussex
    Director
    4 Chawkmare Coppice
    Aldwick
    PO21 3BT Bognor Regis
    West Sussex
    EnglandBritishDirector46424570001
    BURROWS, Alison Jane
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritishDirector123013760002
    BURROWS, Alison Jane
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritishChartered Accountant123013760002
    CLAMPIT, Diane
    99 Chepstow Road
    NN18 8QQ Corby
    Northamptonshire
    Director
    99 Chepstow Road
    NN18 8QQ Corby
    Northamptonshire
    BritishDirector105578650002
    CLARKE, Raymond James
    Sunnybank
    Hickmans Green, Boughton Under Blean
    ME13 9NT Faversham
    Kent
    Director
    Sunnybank
    Hickmans Green, Boughton Under Blean
    ME13 9NT Faversham
    Kent
    BritishDirector58678170002
    CROWFOOT, Martyn Christopher
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritishDirector85033580002
    FURLONG, David
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    Director
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    BritishDirector96183490001
    FURLONG, David
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    Director
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    BritishDirector96183490001
    GARRETT, Michael Stephan
    Wood Lodge
    Lughorse Lane, Yalding
    ME18 6EB Maidstone
    Kent
    Director
    Wood Lodge
    Lughorse Lane, Yalding
    ME18 6EB Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDirector70619210003
    HAMPSON, Anthony Peter
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    UkBritishDirector138791270001
    HARVEY, Paul
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritishDirector175308800001
    HOWIE, Alison Jane
    37 Lavengro Road
    West Norwood
    SE27 9EQ London
    Director
    37 Lavengro Road
    West Norwood
    SE27 9EQ London
    BritishDirector96185200001
    MCGILVRAY, Craig Matthew
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    ScotlandBritishDirector58993260002
    MOODY, Lee Mark
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    United KingdomBritishDirector114275100001
    POSKITT, John Robert
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    United KingdomBritishCompany Director92122220001
    ROGERS, Martin Phillip
    28 Fairfax Road
    NW6 4HA London
    Director
    28 Fairfax Road
    NW6 4HA London
    BritishDirector18752390002
    RUSSELL, Christopher John
    37 Glebe Street
    Chiswick
    W4 2BE London
    Director
    37 Glebe Street
    Chiswick
    W4 2BE London
    BritishDirector96185690001
    SHARP, Howard Graham
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritishChartered Accountant38254450005
    SHARP, Howard Graham
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    Director
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant38254450003
    SHEARMAN, Lesley
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Director
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    United KingdomBritishDirector82540740002
    WALKER, James Newman
    39 Coverside Road
    LE8 9EB Leicester
    Leicestershire
    Director
    39 Coverside Road
    LE8 9EB Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector126676230001
    WEBSTER, Richard Edward
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    Director
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    BritishDirector116347910001
    WEBSTER, Richard Edward
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    Director
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    BritishDirector116347910001
    WHITTINGHAM, Ian Clive
    Swan Mews
    RG29 1DL North Warnborough
    7
    Hampshire
    Director
    Swan Mews
    RG29 1DL North Warnborough
    7
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector151458200001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Director designado corporativo
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EMPRISE PLC?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    City Road
    EC1V 2NT London
    186
    England
    06 abr 2016
    City Road
    EC1V 2NT London
    186
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroUnited Kingdom
    Número de registro4915792
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene EMPRISE PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 12 abr 2013
    Entregado el 26 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 26 abr 2013Registro de una carga (MR01)
    • 30 ago 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 14 may 2007
    Entregado el 19 may 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor or other member of the group to any of the senior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transacciones
    • 19 may 2007Registro de un cargo (395)
    Charge of securities
    Creado el 30 sept 2004
    Entregado el 07 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 jul 2001
    Entregado el 26 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 31 oct 1995
    Entregado el 09 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as ingleby (835) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene EMPRISE PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 jun 2018Inicio de la liquidación
    07 feb 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Neil David Gostelow
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire
    Profesional
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire
    William James Wright
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire
    Profesional
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0