WALKERS SNACK SERVICES LIMITED

WALKERS SNACK SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWALKERS SNACK SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03096955
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WALKERS SNACK SERVICES LIMITED?

    • Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra WALKERS SNACK SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WALKERS SNACK SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GOLDEN WONDER HOLDINGS LIMITED19 oct 199519 oct 1995
    INTERCEDE 1143 LIMITED31 ago 199531 ago 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WALKERS SNACK SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WALKERS SNACK SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    5 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS el 20 feb 2017

    2 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 450 South Oak Way Green Park Reading RG2 6UW a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP el 20 abr 2016

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 31 mar 2016

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 07 ene 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of capital redemption reserve 04/01/2016
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 sept 2015

    Estado de capital el 23 sept 2015

    • Capital: GBP 20,767,511
    SH01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2014 au 30 jun 2015

    3 páginasAA01

    Domicilio social registrado cambiado de 1600 Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SA a 450 South Oak Way Green Park Reading RG2 6UW el 07 sept 2015

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Ms Holly King como secretario el 17 ene 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Sharon Julie Dean como secretario el 17 ene 2015

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 oct 2014

    Estado de capital el 17 oct 2014

    • Capital: GBP 20,767,511
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 dic 2013

    22 páginasAA

    Cese del nombramiento de Walter Todd como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Evans como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Angus Macdonald como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Angus Macdonald como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Angus Macdonald como secretario

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Andrew John Macleod como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de WALKERS SNACK SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KING, Holly
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Secretario
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    195198720001
    AVERISS, Joanne Kerry
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    EnglandBritish57057370001
    ELLINGTON, Ian Lindsay
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    United KingdomBritish146860790001
    EVANS, Victoria Elizabeth
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    EnglandBritish103389550003
    MACDONALD, Angus
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    EnglandBritish188272230001
    MACLEOD, Andrew John
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    United KingdomBritish62169550002
    STONE, Claire Ellen
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Director
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    EnglandBritish111950160001
    AHMED, Anwar Yaseen
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Secretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    176437340001
    AHMED, Anwar Yaseen
    2 St Johns Road
    Tackley
    OX5 3AP Kidlington
    Oxfordshire
    Secretario
    2 St Johns Road
    Tackley
    OX5 3AP Kidlington
    Oxfordshire
    British96045380002
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Secretario
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    British142394800001
    DEAN, Sharon Julie
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Secretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    182653280001
    DEAN, Sharon Julie
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Secretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    148281490002
    MACDONALD, Angus
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Secretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    188462540001
    WILLIAMS, Mark
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    Secretario
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    British76155240003
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    AMIN, Salman
    25 Marlborough Place
    St John's Wood
    NW8 0PG London
    Director
    25 Marlborough Place
    St John's Wood
    NW8 0PG London
    Usa116417620001
    ASHLEY, Jan
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1RH Marlow
    Riversway
    Buckinghamshire
    Director
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1RH Marlow
    Riversway
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish137899880001
    BOOTHMAN, Paul Lister
    Buckley House Thicket Road
    Houghton
    PE17 2BQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Buckley House Thicket Road
    Houghton
    PE17 2BQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish45121570003
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Director
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    EnglandBritish142394800001
    CAMPBELL, Andrew Neil
    Boot Cottage
    Stanford Dingley
    RG7 6LT Reading
    Berkshire
    Director
    Boot Cottage
    Stanford Dingley
    RG7 6LT Reading
    Berkshire
    British67024590002
    DUFFY, John
    12 Devonshire Road
    West Bridgford
    NG2 6EU Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    12 Devonshire Road
    West Bridgford
    NG2 6EU Nottingham
    Nottinghamshire
    British68977480001
    EVANS, Richard David
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Director
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    UkBritish127522770006
    FRASER, Stanley Walter
    48 Grovewood Close
    WD3 5PX Chorleywood
    Hertfordshire
    Director
    48 Grovewood Close
    WD3 5PX Chorleywood
    Hertfordshire
    British68204280001
    GLENN, Martin Richard
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    Director
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    UkBritish61897350002
    HAMPTON, Anthony Nicholas Seymour
    1 High Close
    The Drive
    WD3 4DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    1 High Close
    The Drive
    WD3 4DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish77901460001
    JERVOISE, John Tristram Loveys
    Herriard Park
    RG25 2PL Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Herriard Park
    RG25 2PL Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish45081600001
    JOHNSTON, David William
    Disraeli Road
    Putney
    SW15 0DY London
    111
    Director
    Disraeli Road
    Putney
    SW15 0DY London
    111
    United KingdomBritish275582750001
    JONES, Colin Robert
    Links Road
    HP10 9LY Flackwell Heath
    3
    Buckinghamshire
    Director
    Links Road
    HP10 9LY Flackwell Heath
    3
    Buckinghamshire
    EnglandBritish174775240001
    LORING, Anthony Francis
    2 Wingate Road
    W6 0UR London
    Director
    2 Wingate Road
    W6 0UR London
    British80306770001
    MONK, Paul John
    Pali Gap
    Pinkneys Green
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Pali Gap
    Pinkneys Green
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    British71562530001
    MURRAY, David Thomas
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Director
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    United KingdomIrish150334530001
    NICHOLL, Joseph
    6 Poplars Court
    Leicester Road
    LE16 7BU Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    6 Poplars Court
    Leicester Road
    LE16 7BU Market Harborough
    Leicestershire
    British45121510002
    O'DONNELL, Michael Kane
    Randall House
    18 Woodstock Road
    W4 1UE London
    Director
    Randall House
    18 Woodstock Road
    W4 1UE London
    EnglandIrish107034130001
    ORME, Jackie
    Tomlins
    RG7 6TP Upper Bucklebury
    Berkshire
    Director
    Tomlins
    RG7 6TP Upper Bucklebury
    Berkshire
    EnglandBritish146429980001
    REEVES, Barbara
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    Director designado
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    British900004670001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WALKERS SNACK SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Walkers Snacks Limited
    South Oak Way
    RG2 6UW Reading
    450
    England
    06 abr 2016
    South Oak Way
    RG2 6UW Reading
    450
    England
    No
    Forma jurídicaA Private Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalGoverned By The Law Of England And Wales.
    Lugar de registroUk Registered Company Number:
    Número de registro3474989
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WALKERS SNACK SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture dated 29 july 2000 as amended and restated on 11 august 2000 by a composite restatement agreement dated 10 august 2000 (the "debenture") issued by the company
    Creado el 11 ago 2000
    Entregado el 16 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee all money or liabilities due owing or incurred to any secured party by the charging company or any other charging company under the debenture or any other obligor under any finance document in whatsoever manner
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 16 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed by which the charging company agreed to become bound by the terms of a debenture dated 29 july 2000
    Creado el 29 jul 2000
    Entregado el 02 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the debenture and under any finance document to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transacciones
    • 02 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 23 oct 1995
    Entregado el 10 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Legal & General Ventures Limitedthe "Security Trustee"
    Transacciones
    • 10 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 23 oct 1995
    Entregado el 01 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the deed
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Beneficiaries as Defined Therein) ("the Security Trustee")
    Transacciones
    • 01 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene WALKERS SNACK SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 mar 2016Inicio de la liquidación
    03 jul 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Profesional
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0