SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03109058 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SHL GROUP LIMITED | 19 oct 1995 | 19 oct 1995 |
| TOPMICRO LIMITED | 02 oct 1995 | 02 oct 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 ene 2025 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de James John Moody como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 6 páginas | AA | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Registro de la carga 031090580007, creada el 08 ago 2024 | 23 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Jamie Anthony Keir como director el 31 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Kerry Jenkins como director el 31 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2022 | 3 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Kerry Jenkins como director el 13 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Emmy Bodrogi Hackett como director el 13 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Emmy Bodrogi Hackett como director el 31 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Paul John Greensmith como director el 31 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 24 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2021 | 3 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr James John Moody como director el 25 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nicholas Vivian Malley como director el 25 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 3 páginas | AA | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 80 páginas | PARENT_ACC | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMONDSON, Michael | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 236551420001 | |||||
| KEIR, Jamie Anthony | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 303711290001 | |||||
| BARRETT, Suzanna | Secretario | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | British | 106880710002 | ||||||
| BURNIP, Alexandra Elizabeth | Secretario | 7 Oatlands Close KT13 9ED Weybridge Surrey | British | 12239690001 | ||||||
| CADMAN, John William | Secretario | 42 Albert Road South Woodford E18 1LE London | British | 66894390001 | ||||||
| PHILLIPS, Catherine | Secretario | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | 170385090001 | |||||||
| PRICE, David Robert | Secretario | 1 Titchfield Close RH15 0RX Burgess Hill West Sussex | British | 76272880001 | ||||||
| SEAGER, Graham Gervaise Wilfrid | Secretario | 17 Wycombe Place SW18 2LU London | British | 49342260001 | ||||||
| SWAYNE, Anthony William John | Secretario | The Old Vicarage East Meon GU32 1PG Petersfield Hampshire | British | 23838950006 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARRETT, Suzanna | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 106880710002 | |||||
| BURGE, Alan | Director | Home Farm Close BA14 6AH Steeple Ashton 5 Wiltshire | United Kingdom | British | 197259620001 | |||||
| BURNIP, Alexandra Elizabeth | Director | 7 Oatlands Close KT13 9ED Weybridge Surrey | British | 12239690001 | ||||||
| CADMAN, John William | Director | 42 Albert Road South Woodford E18 1LE London | British | 66894390001 | ||||||
| CRAMP, Elisabeth Lyndsay | Director | 4 Claremont End KT10 9LZ Esher Surrey | England | British | 97695420001 | |||||
| FRANKS, Martin David | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 173954290002 | |||||
| GREENSMITH, Paul John | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 150227000001 | |||||
| GREGORY, Roger William | Director | 26 Magnus Drive Hatch Warren RG22 4TX Basingstoke Hampshire | British | 59500110001 | ||||||
| HACKETT, Emmy Bodrogi | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 137589940001 | |||||
| HOLDSWORTH, Roger Francis | Director | Parc St Roman, 7 Avenue Saint Roman FOREIGN Monaco 98000 Monaco | British | 112662000001 | ||||||
| JENKINS, Kerry | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 125665800001 | |||||
| JOHN EDWARD GILDER, Bateson | Director | The Hale Hale Lane St Leonards HP22 6QR Wendover Buckinghamshire | English | 28185480003 | ||||||
| LANCASTER, Emma Voirrey | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | United Kingdom | British | 79034410005 | |||||
| LIU, Chao | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | Usa | American | 198890410001 | |||||
| MALLEY, Nicholas Vivian | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 271016550001 | |||||
| MOODY, James John | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 292174430001 | |||||
| MYERS, Andrew William | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 101602360003 | |||||
| PHILLIPS, Catherine | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | United Kingdom | British | 170338110001 | |||||
| RYELL, David Edward | Director | The Pavilion 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton Surrey | England | British | 180882130002 | |||||
| SEAGER, Graham Gervaise Wilfrid | Director | 17 Wycombe Place SW18 2LU London | United Kingdom | British | 49342260001 | |||||
| SWAYNE, Anthony William John | Director | The Old Vicarage East Meon GU32 1PG Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 23838950006 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SAVILLE & HOLDSWORTH LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartner, Inc. | 06 abr 2017 | Top Gallant Road Stamford 56 Ct United States | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Shl Group Limited | 06 abr 2016 | 1 Atwell Place KT7 0NE Thames Ditton The Pavilion England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0