SHL (UK) LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHL (UK) LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03109066
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHL (UK) LTD?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra SHL (UK) LTD?

    Dirección de la sede social
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHL (UK) LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SAVILLE & HOLDSWORTH (UK) LIMITED11 dic 199511 dic 1995
    STUDIOPRICE LIMITED02 oct 199502 oct 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHL (UK) LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SHL (UK) LTD?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHL (UK) LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 may 2014

    Estado de capital el 01 may 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Catherine Phillips como director el 31 jul 2013

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    5 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cese del nombramiento de Catherine Phillips como secretario el 31 jul 2013

    1 páginasTM02

    Nombramiento de David Edward Ryell como director el 31 jul 2013

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Emma Voirrey Lancaster como director el 27 nov 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Martin David Franks como director el 27 nov 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Catherine Phillips como secretario el 01 jun 2012

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Suzanna Barrett como secretario el 01 jun 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Suzanna Barrett como director el 01 jun 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Catherine Phillips como director el 01 jun 2012

    2 páginasAP01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mrs Emma Voirrey Lancaster el 10 feb 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Suzanna Barrett el 10 feb 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    7 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    15 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SHL (UK) LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FRANKS, Martin David
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Director
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish173954290001
    RYELL, David Edward
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Director
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish180882130001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    British106880710002
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Secretario
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Secretario
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    EVANS, Paul Anthony James
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Secretario
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British38068300001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    170384570001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Secretario
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Roger John
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British67674990001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Director
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish106880710002
    BURGE, Alan
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    Director
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    United KingdomBritish197259620001
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Director
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Director
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    CRAMP, Elisabeth Lyndsay
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    Director
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    EnglandBritish97695420001
    GREGORY, Roger William
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    Director
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    British59500110001
    HOLDSWORTH, Roger Francis
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    Director
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    British112662000001
    HOWARD, Simon John
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    Director
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    United KingdomBritish73313240006
    LANCASTER, Emma Voirrey
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Director
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish79034410005
    MABEY, William
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    Director
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    British12239710001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Director
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish170338110001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Director
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SAVILLE, Peter Francis, Dr
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Director
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    British12239700001
    STEVENSON, Hazel Helena
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    Director
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish51232470001
    VAN RAAY, Paul Bernard
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Director
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Dutch90966240001
    VISSER, Gerbrand Joannes Antonius
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Director
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Dutch51232680001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene SHL (UK) LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 10 ene 2011
    Entregado el 15 ene 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Cit Capital Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 15 ene 2011Registro de un cargo (MG01)
    A share pledge agreement
    Creado el 27 mar 2009
    Entregado el 06 abr 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The pledgors have pledged the 12,434 shares no.1 To 12,434 shares inclusive held by shl people solutions group holdings limited and one share no.12,435 Held by the company in shl belgium sa and any other shares in shl belgium that they may subscribe to or acquire in the future see image for full details.
    Personas con derecho
    • Cit Capital Finance (UK) Limited Acting for Itself and for the Account of the Secured Parties
    Transacciones
    • 06 abr 2009Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 27 mar 2009
    Entregado el 06 abr 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Cit Capital Finance (UK) Limited as Trustee for Itself and the Other Persons (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 abr 2009Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 31 ene 2007
    Entregado el 07 feb 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cit Capital Finance (UK) Limited in Its Capacity Trustee
    Transacciones
    • 07 feb 2007Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 19 ago 1997
    Entregado el 08 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 08 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 16 ene 1997
    Entregado el 22 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0