REBUS GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREBUS GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03109650
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REBUS GROUP LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra REBUS GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
    5 Churchill Place, 10th Floor
    E14 5HU London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REBUS GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RICHTRACK PUBLIC LIMITED COMPANY03 oct 199503 oct 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REBUS GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REBUS GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 páginasPSC08

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Cessation de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 jul 2021

    1 páginasPSC07

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Estado de capital el 07 may 2021

    • Capital: GBP 0.02
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    58 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2021 au 31 dic 2020

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 03 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Notification de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov 2019

    2 páginasPSC01

    Cessation de Rebus Hr Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov 2019

    1 páginasPSC07

    Domicilio social registrado cambiado de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor London E14 5HU el 04 nov 2020

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Andrew Phillip Monshaw como director el 21 oct 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Malcolm Robert Bennett como secretario el 10 jul 2020

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Steven James Chalker como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Gillian Tiffney Gilliat Nolan como director el 30 jun 2020

    2 páginasAP01

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    ¿Quiénes son los directivos de REBUS GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NOLAN, Gillian Tiffney Gilliatt
    5 Churchill Place, 10th Floor
    E14 5HU London
    C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
    United Kingdom
    Director
    5 Churchill Place, 10th Floor
    E14 5HU London
    C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish271694390001
    BENNETT, Malcolm Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    208002930001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    British75357260001
    LONEY, Nicholas John
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    Secretario
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    British8511300001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Secretario
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Secretario
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Secretario
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    BIDWELL, Hugh Charles Philip, Sir
    The Parsonage
    Goodnestone
    CT3 1PJ Canterbury
    Kent
    Director
    The Parsonage
    Goodnestone
    CT3 1PJ Canterbury
    Kent
    British58932210001
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    Director
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    British63922600001
    CHALKER, Steven James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish221085650001
    COTTAM, Harold, Managing Director
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    Director
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    United KingdomBritish32116700002
    DENLEY, Gareth Phillip
    31 Ashley Road
    KT12 1JB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    31 Ashley Road
    KT12 1JB Walton On Thames
    Surrey
    British38711220001
    GREAVES, Andrew David
    Wood End Cottage Wood Lane
    SL2 3YY Hedgerley
    Buckinghamshire
    Director
    Wood End Cottage Wood Lane
    SL2 3YY Hedgerley
    Buckinghamshire
    British50048250001
    HELLER, Robert Gordon Barry
    53 Fitzroy Park
    N6 6JA London
    Director
    53 Fitzroy Park
    N6 6JA London
    British2883040001
    HODGSON, David Charles
    755 Park Avenue
    New York 10021
    Usa
    Director
    755 Park Avenue
    New York 10021
    Usa
    American63989560001
    LAKING, David Albert
    33 Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    Director
    33 Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish82424930001
    LONEY, Nicholas John
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    Director
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    British8511300001
    MCKINLEY, Edward Joseph
    The Priory
    3a Seymour Walk
    SW10 9NF London
    Director
    The Priory
    3a Seymour Walk
    SW10 9NF London
    American38853950001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Director
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    MONSHAW, Andrew Phillip
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    Director
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    United StatesAmerican239664830001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Director
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    ROSS, Stuart
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish20168110001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Director
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    SEED, John Junior
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    Director
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    British8670120001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    SUMMERS, Roger Denis
    15 Five Acres
    Danbury
    CM3 4NB Chelmsford
    Essex
    Director
    15 Five Acres
    Danbury
    CM3 4NB Chelmsford
    Essex
    British8559710001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Director designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de REBUS GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Stephen Allen Schwarzman
    Park Ave
    NY 10154 New York
    345
    United States
    04 nov 2019
    Park Ave
    NY 10154 New York
    345
    United States
    Nacionalidad: American
    País de residencia: United States
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Rebus Hr Holdings Limited
    Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    England
    03 oct 2016
    Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    England
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroUk Companies House
    Número de registro03719768
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para REBUS GROUP LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    06 jul 2021La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene REBUS GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 jun 2016
    Entregado el 23 jun 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Nil.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 23 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    • 02 feb 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A grant of security interest in trademark rights
    Creado el 19 abr 2011
    Entregado el 04 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design reg no: 2,940,278 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 05 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A grant of security interest in trademark rights
    Creado el 19 abr 2011
    Entregado el 04 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design, reg no:2,940,278 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 05 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Intellectual property security agreement
    Creado el 19 abr 2011
    Entregado el 03 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Intellectual property being registered trademarks and trademark applications in rebus group limited, trademark star design, all proceeds and products of the foregoing, see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 05 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A deed of accession
    Creado el 29 abr 2008
    Entregado el 12 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 12 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2008
    • 21 may 2008
    • 05 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A supplemental debenture
    Creado el 09 jul 1999
    Entregado el 28 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein)
    Breve descripción
    All freehold and leasehold property and all assets and undertakings.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent for and on Behalf of the Financeparties (As Defined in the Supplemental Debenture)
    Transacciones
    • 28 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 18 mar 1999
    Entregado el 30 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents defined therein
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited(Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuant to the Facilities Agreement)
    Transacciones
    • 30 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 mar 1996
    Entregado el 27 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 27 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0