REBUS GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | REBUS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03109650 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de REBUS GROUP LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra REBUS GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor E14 5HU London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REBUS GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RICHTRACK PUBLIC LIMITED COMPANY | 03 oct 1995 | 03 oct 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de REBUS GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para REBUS GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Cessation de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 jul 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Estado de capital el 07 may 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 58 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT1 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2021 au 31 dic 2020 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov 2019 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Cessation de Rebus Hr Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor London E14 5HU el 04 nov 2020 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Phillip Monshaw como director el 21 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Robert Bennett como secretario el 10 jul 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven James Chalker como director el 30 jun 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Gillian Tiffney Gilliat Nolan como director el 30 jun 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE1 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de REBUS GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLAN, Gillian Tiffney Gilliatt | Director | 5 Churchill Place, 10th Floor E14 5HU London C/O Corporation Service Company (Uk) Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 271694390001 | |||||
| BENNETT, Malcolm Robert | Secretario | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | 208002930001 | |||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Secretario | 51 The Avenue WD17 4NU Watford Hertfordshire | British | 75357260001 | ||||||
| LONEY, Nicholas John | Secretario | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
| MEADES, Derek Leslie | Secretario | Alfriston House The Avenue SL5 7LY Ascot Berkshire | British | 8142960002 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secretario | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||
| RICHARDSON, John David | Secretario | High Street Burnham SL1 7JD Slough 27 Berks | British | 128558470001 | ||||||
| SCHENCK, Daniel William | Secretario | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||
| SCORE, Timothy | Secretario | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Director | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||
| BIDWELL, Hugh Charles Philip, Sir | Director | The Parsonage Goodnestone CT3 1PJ Canterbury Kent | British | 58932210001 | ||||||
| BURTON, Michael John | Director | 4a Langton Way SE3 7TL London | British | 63922600001 | ||||||
| CHALKER, Steven James | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 221085650001 | |||||
| COTTAM, Harold, Managing Director | Director | Pentwyn Farm Dorstone HR3 6AD Hereford | United Kingdom | British | 32116700002 | |||||
| DENLEY, Gareth Phillip | Director | 31 Ashley Road KT12 1JB Walton On Thames Surrey | British | 38711220001 | ||||||
| GREAVES, Andrew David | Director | Wood End Cottage Wood Lane SL2 3YY Hedgerley Buckinghamshire | British | 50048250001 | ||||||
| HELLER, Robert Gordon Barry | Director | 53 Fitzroy Park N6 6JA London | British | 2883040001 | ||||||
| HODGSON, David Charles | Director | 755 Park Avenue New York 10021 Usa | American | 63989560001 | ||||||
| LAKING, David Albert | Director | 33 Station Road Nassington PE8 6QB Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 82424930001 | |||||
| LONEY, Nicholas John | Director | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
| MCKINLEY, Edward Joseph | Director | The Priory 3a Seymour Walk SW10 9NF London | American | 38853950001 | ||||||
| MEADES, Derek Leslie | Director | Alfriston House The Avenue SL5 7LY Ascot Berkshire | British | 8142960002 | ||||||
| MONSHAW, Andrew Phillip | Director | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Herts | United States | American | 239664830001 | |||||
| PRESLAND, Peter Eric | Director | Rats Castle Castletons Oak Cranbrook Road TN27 8DY Biddenden Ashford Kent | England | British | 7649630002 | |||||
| ROSS, Stuart | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 20168110001 | |||||
| SCORE, Timothy | Director | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| SEED, John Junior | Director | Highfield House North Road BA2 6HW Bath Bath & North East Somerset | British | 8670120001 | ||||||
| STIER, John Robert | Director | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Director | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||
| SUMMERS, Roger Denis | Director | 15 Five Acres Danbury CM3 4NB Chelmsford Essex | British | 8559710001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Director designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de REBUS GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Stephen Allen Schwarzman | 04 nov 2019 | Park Ave NY 10154 New York 345 United States | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Rebus Hr Holdings Limited | 03 oct 2016 | Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para REBUS GROUP LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 06 jul 2021 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene REBUS GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 20 jun 2016 Entregado el 23 jun 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Nil. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A grant of security interest in trademark rights | Creado el 19 abr 2011 Entregado el 04 may 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design reg no: 2,940,278 see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A grant of security interest in trademark rights | Creado el 19 abr 2011 Entregado el 04 may 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design, reg no:2,940,278 see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Intellectual property security agreement | Creado el 19 abr 2011 Entregado el 03 may 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Intellectual property being registered trademarks and trademark applications in rebus group limited, trademark star design, all proceeds and products of the foregoing, see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A deed of accession | Creado el 29 abr 2008 Entregado el 12 may 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A supplemental debenture | Creado el 09 jul 1999 Entregado el 28 jul 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein) | |
Breve descripción All freehold and leasehold property and all assets and undertakings. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 18 mar 1999 Entregado el 30 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents defined therein | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 mar 1996 Entregado el 27 mar 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0