INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED

INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03110970
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    • Actividades de agentes y corredores de seguros (66220) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Walbrook Building
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 29 oct 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Ms Carol Richmond el 17 mar 2020

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    20 páginasAA

    Nombramiento de Mr Alistair Charles Peel como secretario el 10 ago 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de William Lindsay Mcgowan como secretario el 10 ago 2018

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Charles Douglas Scott como director el 09 jul 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Graham Story como director el 30 jun 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Matthew William Pike como director el 07 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    22 páginasAA

    Nombramiento de Mr Michael Peter Rea como director el 18 jul 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Carol Richmond como director el 18 jul 2016

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PEEL, Alistair Charles
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Secretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    249460250001
    REA, Michael Peter
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    EnglandBritish202798810001
    RICHMOND, Carol Ann
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    United KingdomBritish202816810002
    SCOTT, Charles Douglas
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    EnglandBritish195849440001
    GARDNER, Derek Gordon
    11 Ravelston House Grove
    EH4 3LT Edinburgh
    Secretario
    11 Ravelston House Grove
    EH4 3LT Edinburgh
    British76358670005
    HESSETT, Alastair George
    Eaglesham Road
    Newton Mearns
    G77 5BG Glasgow
    14a
    Secretario
    Eaglesham Road
    Newton Mearns
    G77 5BG Glasgow
    14a
    British128563670001
    MCCARTHY, Michael Edward
    79 St John Street
    EC1M 4DR London
    Secretario
    79 St John Street
    EC1M 4DR London
    British31153510001
    MCGOWAN, William Lindsay
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Secretario
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    183161610001
    THOMAS, Philip Donald
    20-21 Cliff Parade
    SS9 1AS Leigh On Sea
    Essex
    Secretario
    20-21 Cliff Parade
    SS9 1AS Leigh On Sea
    Essex
    English61517690002
    EXPECTRUM SECRETARIES LIMITED
    Floor
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court 3rd
    England
    Secretario corporativo
    Floor
    Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court 3rd
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro08457527
    179630700001
    ADDIS, Mark
    Queens Road
    BR3 4JJ Beckenham
    37
    Kent
    Director
    Queens Road
    BR3 4JJ Beckenham
    37
    Kent
    United KingdomBritish140899270001
    ARDEN, Jeremy Michael Ashby
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    United KingdomBritish162978150001
    CHAMBERS, Mark Russell
    Birchin Court
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Third Floor
    Director
    Birchin Court
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Third Floor
    EnglandBritish155255190001
    DALGARNO, Sarah
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    EnglandBritish134081320001
    GARDNER, Derek Gordon
    11 Ravelston House Grove
    EH4 3LT Edinburgh
    Director
    11 Ravelston House Grove
    EH4 3LT Edinburgh
    United KingdomBritish76358670005
    GILES, Christopher Michael
    18 The Barton
    KT11 2NJ Cobham
    Surrey
    Director
    18 The Barton
    KT11 2NJ Cobham
    Surrey
    EnglandBritish44474540003
    LINCOLN, John Edward
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    United KingdomBritish178228000001
    LYONS, Sarah Elizabeth
    48 Wellfield Road
    HD3 4BJ Lindley
    West Yorkshire
    Director
    48 Wellfield Road
    HD3 4BJ Lindley
    West Yorkshire
    EnglandBritish125660560001
    MAGEEAN, Bernard
    3rd Floor
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court
    Director
    3rd Floor
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court
    EnglandBritish171821890001
    MATSON, Paul Dominic
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    United KingdomBritish132696680003
    MATSON, Paul Dominic
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Third Floor Birchin Court
    Director
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Third Floor Birchin Court
    United KingdomBritish132696680003
    MCINTYRE, Hazel Jane
    Cluny Gardens
    EH10 6BN Edinburgh
    38
    Director
    Cluny Gardens
    EH10 6BN Edinburgh
    38
    ScotlandBritish86240240004
    MCMANUS, Brendan James
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    United KingdomBritish128122260001
    MUGGE, Mark Stephen
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    U.K.-EnglandAmerican162920630002
    PIKE, Matthew William
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    EnglandBritish194556730001
    PRESCOTT, George Andrew
    Fauconberg Road
    W4 3EE Chiswick
    120
    London
    Director
    Fauconberg Road
    W4 3EE Chiswick
    120
    London
    United KingdomBritish27000650003
    ROSS, David Christopher
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    United KingdomIrish222326970001
    ROYLE, Andy
    3rd Floor
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court
    Director
    3rd Floor
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court
    United KingdomBritish169037530001
    SCALES, Matthew
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    England
    EnglandBritish5935870005
    SMITH, Michael David
    3rd Floor
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court
    Director
    3rd Floor
    20 Birchin Lane
    EC3V 9DU London
    Birchin Court
    EnglandBritish79783760001
    STORY, Ian Graham
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    Director
    25 Walbrook
    EC4N 8AW London
    The Walbrook Building
    EnglandBritish195942410001
    SYRETT, Keith Derek
    31a Clarence Road
    SS6 8TA Rayleigh
    Essex
    Director
    31a Clarence Road
    SS6 8TA Rayleigh
    Essex
    British12560220002
    THOMAS, Lynda Helen
    20-21 Cliff Parade
    SS9 1AS Leigh On Sea
    Essex
    Director
    20-21 Cliff Parade
    SS9 1AS Leigh On Sea
    Essex
    British9190630003
    THOMAS, Philip Donald
    20-21 Cliff Parade
    SS9 1AS Leigh On Sea
    Essex
    Director
    20-21 Cliff Parade
    SS9 1AS Leigh On Sea
    Essex
    United KingdomEnglish61517690002
    WATSON, John Frank
    1 Grove Close
    SS6 8QU Rayleigh
    Essex
    Director
    1 Grove Close
    SS6 8QU Rayleigh
    Essex
    British94815320001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Quillco 227 Limited
    55 Blythswood Street
    G2 7AT Glasgow
    Spectrum Building, 7th Floor
    Scotland
    06 abr 2016
    55 Blythswood Street
    G2 7AT Glasgow
    Spectrum Building, 7th Floor
    Scotland
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroScotland
    Número de registroSc304651
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene INK UNDERWRITING AGENCIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 abr 2008
    Entregado el 26 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company to any secured party under any finance document on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 mar 2008
    Entregado el 11 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company and any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transacciones
    • 11 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 17 ago 2007
    Entregado el 30 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creado el 21 ene 2003
    Entregado el 05 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or P.D.T.insurance consultants limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0