VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED

VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03113951
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Third Floor International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    England
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VACANT PROPERTY SECURITY (MIDLANDS) LIMITED23 feb 199623 feb 1996
    MAXAM SECURITY SERVICES (MIDLANDS) LIMITED02 ene 199602 ene 1996
    SHEENBRIDGE ENGINEERING LIMITED 16 oct 199516 oct 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 oct 2016 con actualizaciones

    10 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Keith Alan Reid como director el 06 oct 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr James Darnton como director el 06 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Jonathan Silver como director el 25 may 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David James Benwell Taylor-Smith como director el 23 may 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Suzanne Claire Hardyman como secretario el 14 mar 2016

    2 páginasAP03

    Domicilio social registrado cambiado de Premiere House Elstree Way Borehamwood Hertfordshire WD6 1JH a Third Floor International Buildings 71 Kingsway London England WC2B 6st el 22 mar 2016

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Timothy Joseph Gerard O'gorman como secretario el 08 ene 2016

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 nov 2015

    Estado de capital el 09 nov 2015

    • Capital: GBP 280,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 oct 2014

    Estado de capital el 20 oct 2014

    • Capital: GBP 280,000
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Resolution pass/company members entitled to attend and vote at a general meeting of the ccompany 17/07/2014
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    11 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HARDYMAN, Suzanne Claire
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    Secretario
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    206374920001
    DARNTON, James
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    Director
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    EnglandBritishGroup Chief Financial Officer51472910003
    TAYLOR-SMITH, David James Benwell
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    Director
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    United KingdomBritishDirector126197410002
    BOWES, Michael Robert
    Modus Novem Goodiers Lane
    Twyning
    GL20 6DJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Secretario
    Modus Novem Goodiers Lane
    Twyning
    GL20 6DJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    British40475870001
    JAMES, Stephen William
    4a Felden Drive
    Felden
    HP3 0BD Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    4a Felden Drive
    Felden
    HP3 0BD Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishCompany Director155945200001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Secretario
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    BritishChartered Secretary37404250003
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    162800710001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Secretario designado corporativo
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BATES, Christopher Ralph
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51622580004
    BAUMBER, Marcus
    4 Alder Close
    North Petherton
    TA6 6TT Bridgwater
    Somerset
    Director
    4 Alder Close
    North Petherton
    TA6 6TT Bridgwater
    Somerset
    BritishDirector109607530001
    BHARAJ, Simar Kaur
    c/o Vps Property Services
    Low Moor Industrial Estate, Common Road
    Low Moor
    BD12 0NB Bradford
    10
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Vps Property Services
    Low Moor Industrial Estate, Common Road
    Low Moor
    BD12 0NB Bradford
    10
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director133408960001
    BOWES, Michael Robert
    Modus Novem Goodiers Lane
    Twyning
    GL20 6DJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    Modus Novem Goodiers Lane
    Twyning
    GL20 6DJ Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director40475870001
    BRISTOW, James Terence
    Challock House Canterbury Road
    Challock
    TN25 4DL Ashford
    Kent
    Director
    Challock House Canterbury Road
    Challock
    TN25 4DL Ashford
    Kent
    EnglandBritishManager25211850002
    BROADBENT, Simon Charles
    50 King Street
    BB7 2EU Clitheroe
    Lancashire
    Director
    50 King Street
    BB7 2EU Clitheroe
    Lancashire
    United KingdomBritishManager98996940001
    FOX-ANDREWS, Piers Norman James
    Fair Oak
    Rogate
    GU31 5HR Petersfield
    Hampshire
    Director
    Fair Oak
    Rogate
    GU31 5HR Petersfield
    Hampshire
    BritishCompany Director45730620001
    JAMES, Stephen William
    Elstree Business Centre,
    Elstree Way, Borehamwood
    WD6 1RX Hertfordshire
    Director
    Elstree Business Centre,
    Elstree Way, Borehamwood
    WD6 1RX Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director155945200001
    QUINLAN, Ian
    Elstree Business Centre,
    Elstree Way, Borehamwood
    WD6 1RX Hertfordshire
    Director
    Elstree Business Centre,
    Elstree Way, Borehamwood
    WD6 1RX Hertfordshire
    EnglandBritishManager2521720004
    REID, Keith Alan
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Elstree Way
    WD6 1JH Borehamwood
    Premiere House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishAccountant163383440001
    SILVER, Mark Jonathan
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    Director
    International Buildings
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor
    England
    England
    United KingdomBritishDirector157553670001
    SWANN, Brian George
    Low Moor Industrial Estate, Common Road
    Low Moor
    BD12 0NB Bradford
    Unit 10
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Low Moor Industrial Estate, Common Road
    Low Moor
    BD12 0NB Bradford
    Unit 10
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector200010830001
    WHITE, David Anthony
    Lett's Green House New Years Lane
    Knockholt
    TN14 7PG Sevenoaks
    Kent
    Director
    Lett's Green House New Years Lane
    Knockholt
    TN14 7PG Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishCompany Director45730590002
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Director designado corporativo
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    06 abr 2016
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4835721
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    06 abr 2016
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro8994051
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    06 abr 2016
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro08994063
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    06 abr 2016
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro08917956
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    06 abr 2016
    71 Kingsway
    WC2B 6ST London
    Third Floor, International Buildings
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro08922409
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Targaryen Security 1 S.A.R.L.
    Allee Scheffer
    Luxembourg 2520
    43-45
    Luxembourg
    06 abr 2016
    Allee Scheffer
    Luxembourg 2520
    43-45
    Luxembourg
    No
    Forma jurídicaS.A.R.L.
    País de registroLuxembourg
    Autoridad legalLuxembourg
    Lugar de registroRegistre De Commerce Et Des Societes
    Número de registroB187842
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene VPS VACANT PROPERTY SPECIALISTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    State of pledge over financial securities account executed outside the united kingdom over property situated there
    Creado el 07 ago 2009
    Entregado el 22 oct 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The pledged securities account see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent) and the Banks and Financial Institutions Parties to the Facilities Agreement as Defined on the Form 395
    Transacciones
    • 22 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 19 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 13 mar 2009
    Entregado el 27 mar 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The initial rent deposit being £1,908 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Mansfield District Council
    Transacciones
    • 27 mar 2009Registro de un cargo (395)
    • 25 jul 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 04 jul 2007
    Entregado el 07 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £3,953.87 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    Rent deposit account.
    Personas con derecho
    • Landleaf Gp Limited and Northern Industrial (General Partners) Limited
    Transacciones
    • 07 jul 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 11 abr 2007
    Entregado el 13 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share account pledge agreement
    Creado el 05 ene 2005
    Entregado el 19 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The pledged account. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland and National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Declaration of pledge over share account
    Creado el 05 ene 2005
    Entregado el 19 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The pledged account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland and National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 20 dic 2004
    Entregado el 30 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The real property and all interest, all plant and machinery, all computers and benefit of all contracts licences and warranties, all charges securities, the security accounts, all monies standing to the credit on any and all accounts, the intellectual property rights, the goodwill and uncalled capital. Floating charge the assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transacciones
    • 30 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0