GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03114400 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?
Dirección de la sede social | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SHAREHOLDER COMMUNICATIONS PLC | 20 feb 1998 | 20 feb 1998 |
SHAREHOLDER COMMUNICATIONS CORPORATION (UK) PLC | 16 oct 1995 | 16 oct 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 29 abr 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Andrew Mills como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
legacy | 9 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 7 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 7 páginas | MG02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 oct 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Dolbear como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2010 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Nazir Sarkar como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Morris como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 oct 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Hood como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2009 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield el 15 abr 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTHA, Llewellyn Kevan | Secretario | Penthouse A, Spring Leigh Church Road, Leigh Woods BS8 3PG Bristol North Somerset | South African | Lawyer | 105560560001 | |||||
DOLBEAR, Jonathan | Secretario | The Pavilions Bridgwater Road BS13 8AE Bristol | 161908810001 | |||||||
BOTHA, Llewellyn Kevan | Director | Penthouse A, Spring Leigh Church Road, Leigh Woods BS8 3PG Bristol North Somerset | United Kingdom | South African | Lawyer | 105560560001 | ||||
MILLS, Christopher Andrew | Director | Park Lane, Blagdon BS40 7SB Bristol Heronmere England | England | British | Uci Finance Director | 178211930001 | ||||
OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert | Director | Holt Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill BS40 8QR Chew Magna Greenleigh Farm Bristol England | England | British | Director Of Corporate Developm | 116701010001 | ||||
SARKAR, Nazir | Director | Pier Road Portishead BS20 7DZ Bristol Whitehaven | United Kingdom | British | Director | 157131040003 | ||||
COE, Lorraine Elizabeth | Secretario | 3 St Albans Road IG8 9EQ Woodford Green Essex | British | 24485080001 | ||||||
CORNEY, Darryl John | Secretario | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | Finance Executive | 83564940010 | |||||
DEVON, David John | Secretario | Lynwood Camden Road DA5 3NP Bexley Kent | British | 7756250002 | ||||||
DUDLEY, Michael Charles | Secretario | High Timber Chislehurst Road BR7 5LD Chislehurst Kent | British | Director | 60270470001 | |||||
GREENHALGH, John William | Secretario | 5 Coutts Crescent NW5 1RF London | British | Director | 15630560001 | |||||
HOPKINSON, Ian Michael | Secretario | 10 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 53858740001 | |||||
BAILES, David Delisle | Director | Flat C 66 Elm Park Road SW3 6AU London | South African | Director | 92919610001 | |||||
BORONKAY, Ronald | Director | 17 State Street NY 1000Y New York Usa | Us Citizen | Executive | 62203530002 | |||||
CHANDOHA, Walter Sam | Director | 333 East 79th Street Apt Phn New York Ny 10021 Usa | American | Director | 62029490001 | |||||
CHAPMAN, Robert William Frederick | Director | Lough Beltra 76 Lymington Bottom, Four Marks GU34 5AH Alton Hampshire | United Kingdom | British | Director | 110216200001 | ||||
CORNEY, Darryl John | Director | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | England | British | Finance Executive | 83564940010 | ||||
CROSBY, William Stuart | Director | 705 Tead Froad Shad Thames SE1 2AS London | Australian | Chief Operating Officer | 108743530001 | |||||
DEVON, David John | Director | 25 New Street Square EC4A 3LN London | British | Chartered Accountant | 7756250001 | |||||
DUDLEY, Michael Charles | Director | High Timber Chislehurst Road BR7 5LD Chislehurst Kent | Uk | British | Director | 60270470001 | ||||
GREENHALGH, John William | Director | 5 Coutts Crescent NW5 1RF London | United Kingdom | British | Director | 15630560001 | ||||
HOOD, James Terence | Director | Redland Road BS6 6YA Bristol 140b Avon United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 189833420001 | ||||
HOPKINSON, Ian Michael | Director | 10 Harvest Bank Hyde Heath HP6 5RD Amersham Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 53858740001 | |||||
MARSHALL, Timothy Thomas | Director | 9 Trentishoe Mansions 90 Charing Cross Road WC2H 0JE London | American | Financial Consultant | 87963030001 | |||||
MILLER, Alexander | Director | 17 State Street New York Ny 1000y | Us Citizen | Executive | 57588460002 | |||||
MORRIS, Christopher John | Director | 608 Spice Quay Heights 32 Shad Thames SE1 2YL London | Australia | Australian | Chief Executive Officer | 114812600001 | ||||
PALMER, Samantha | Director | 17 Athelstan Road ME4 6EJ Chatham Kent | British | Corporate Compliance Assistant | 52210680002 | |||||
SMITH, Jason Leigh | Director | 2 Providence Lane Long Ashton BS41 9DG Bristol | Australian | Chief Financial Officer | 115310950001 | |||||
TYSON, Roger Thomas Virley | Director | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | England | British | Chief Executive | 113777700001 |
¿Tiene GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Pledge agreement | Creado el 22 sept 2003 Entregado el 03 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 22 sept 2003 Entregado el 26 sept 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 16 jun 1998 Entregado el 25 jun 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the guarantee or the credit agreement of even date | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0