GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED

GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03114400
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHAREHOLDER COMMUNICATIONS PLC20 feb 199820 feb 1998
    SHAREHOLDER COMMUNICATIONS CORPORATION (UK) PLC16 oct 199516 oct 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 29 abr 2014

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2013

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Christopher Andrew Mills como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    legacy

    9 páginasMG02

    legacy

    7 páginasMG02

    legacy

    7 páginasMG02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Jonathan Dolbear como secretario

    1 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2010

    15 páginasAA

    Nombramiento de Nazir Sarkar como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Morris como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 16 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de James Hood como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2009

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Stuart Robert Oldfield el 15 abr 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Secretario
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    South AfricanLawyer105560560001
    DOLBEAR, Jonathan
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    Secretario
    The Pavilions
    Bridgwater Road
    BS13 8AE Bristol
    161908810001
    BOTHA, Llewellyn Kevan
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    Director
    Penthouse A, Spring Leigh
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    North Somerset
    United KingdomSouth AfricanLawyer105560560001
    MILLS, Christopher Andrew
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    Director
    Park Lane, Blagdon
    BS40 7SB Bristol
    Heronmere
    England
    EnglandBritishUci Finance Director178211930001
    OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    Director
    Holt
    Greenleigh Farm Holt Limeburn Hill
    BS40 8QR Chew Magna
    Greenleigh Farm
    Bristol
    England
    EnglandBritishDirector Of Corporate Developm116701010001
    SARKAR, Nazir
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    Director
    Pier Road
    Portishead
    BS20 7DZ Bristol
    Whitehaven
    United KingdomBritishDirector157131040003
    COE, Lorraine Elizabeth
    3 St Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    Secretario
    3 St Albans Road
    IG8 9EQ Woodford Green
    Essex
    British24485080001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Secretario
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    BritishFinance Executive83564940010
    DEVON, David John
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    Secretario
    Lynwood
    Camden Road
    DA5 3NP Bexley
    Kent
    British7756250002
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Secretario
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    BritishDirector60270470001
    GREENHALGH, John William
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    Secretario
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    BritishDirector15630560001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant53858740001
    BAILES, David Delisle
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Director
    Flat C
    66 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    South AfricanDirector92919610001
    BORONKAY, Ronald
    17 State Street
    NY 1000Y New York
    Usa
    Director
    17 State Street
    NY 1000Y New York
    Usa
    Us CitizenExecutive62203530002
    CHANDOHA, Walter Sam
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Director
    333 East 79th Street
    Apt Phn
    New York
    Ny 10021
    Usa
    AmericanDirector62029490001
    CHAPMAN, Robert William Frederick
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    Director
    Lough Beltra
    76 Lymington Bottom, Four Marks
    GU34 5AH Alton
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector110216200001
    CORNEY, Darryl John
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    Highcroft
    Milton Clevedon
    BA4 6NS Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritishFinance Executive83564940010
    CROSBY, William Stuart
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    Director
    705 Tead Froad
    Shad Thames
    SE1 2AS London
    AustralianChief Operating Officer108743530001
    DEVON, David John
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    Director
    25 New Street Square
    EC4A 3LN London
    BritishChartered Accountant7756250001
    DUDLEY, Michael Charles
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    Director
    High Timber Chislehurst Road
    BR7 5LD Chislehurst
    Kent
    UkBritishDirector60270470001
    GREENHALGH, John William
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    Director
    5 Coutts Crescent
    NW5 1RF London
    United KingdomBritishDirector15630560001
    HOOD, James Terence
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    Director
    Redland Road
    BS6 6YA Bristol
    140b
    Avon
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant189833420001
    HOPKINSON, Ian Michael
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    10 Harvest Bank
    Hyde Heath
    HP6 5RD Amersham
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant53858740001
    MARSHALL, Timothy Thomas
    9 Trentishoe Mansions
    90 Charing Cross Road
    WC2H 0JE London
    Director
    9 Trentishoe Mansions
    90 Charing Cross Road
    WC2H 0JE London
    AmericanFinancial Consultant87963030001
    MILLER, Alexander
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Director
    17 State Street
    New York
    Ny 1000y
    Us CitizenExecutive57588460002
    MORRIS, Christopher John
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Director
    608 Spice Quay Heights
    32 Shad Thames
    SE1 2YL London
    AustraliaAustralianChief Executive Officer114812600001
    PALMER, Samantha
    17 Athelstan Road
    ME4 6EJ Chatham
    Kent
    Director
    17 Athelstan Road
    ME4 6EJ Chatham
    Kent
    BritishCorporate Compliance Assistant52210680002
    SMITH, Jason Leigh
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    Director
    2 Providence Lane
    Long Ashton
    BS41 9DG Bristol
    AustralianChief Financial Officer115310950001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Director
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishChief Executive113777700001

    ¿Tiene GEORGESON SHAREHOLDER COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Pledge agreement
    Creado el 22 sept 2003
    Entregado el 03 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Provident Bank
    Transacciones
    • 03 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 22 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 sept 2003
    Entregado el 26 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Provident Bank (The "Agent")
    Transacciones
    • 26 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 22 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 16 jun 1998
    Entregado el 25 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the guarantee or the credit agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Provident Bank
    Transacciones
    • 25 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 22 ago 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0