CHUBB LONDON GROUP LIMITED

CHUBB LONDON GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHUBB LONDON GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03115073
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ACE LONDON GROUP LIMITED14 jul 199814 jul 1998
    ACE UK LIMITED20 nov 199520 nov 1995
    3046TH SINGLE MEMBER SHELF TRADING COMPANY LIMITED19 oct 199519 oct 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 sept 2022

    9 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD a 30 Old Bailey London EC4M 7AU el 11 may 2022

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    16 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 sept 2021

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 sept 2020

    9 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 13 sept 2019

    9 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP United Kingdom a Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD el 22 oct 2018

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP

    2 páginasAD02

    Declaración de solvencia

    6 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 14 sept 2018

    LRESSP

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital16 jun 2016

    Estado de capital el 16 jun 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cambio de datos del secretario Ace London Services Limited el 30 mar 2016

    1 páginasCH04

    Memorándum y Estatutos

    25 páginasMA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed ace london group LIMITED\certificate issued on 30/03/16
    2 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name30 mar 2016

    Cambio de nombre por disposición en los estatutos

    NM04

    Domicilio social registrado cambiado de Ace Building 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP a 100 Leadenhall Street London EC3A 3BP el 25 feb 2016

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del secretario Ace London Services Limited el 24 feb 2016

    1 páginasCH04

    Nombramiento de Ashley Craig Mullins como director el 05 feb 2016

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHUBB LONDON SERVICES LIMITED
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro03115073
    73849550003
    HAMMOND, Mark Kent
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Director
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomAmerican174190760002
    KENDRICK, Andrew James
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    Director
    Old Bailey
    EC4M 7AU London
    30
    United KingdomBritish62276900004
    MULLINS, Ashley Craig
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    Director
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    EnglandAustralian205193200001
    BROWN, Alexander Johnston
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    Secretario
    4 The Grangeway
    Grange Park
    N21 2HA London
    British2569760001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secretario
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretario designado corporativo
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    CHARMAN, John Robert
    Dell House Wilderness Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Director
    Dell House Wilderness Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    British14016810001
    CIGELNIK, Randi Lyn
    28 Pilgrims Lane
    NW3 1SN London
    Director
    28 Pilgrims Lane
    NW3 1SN London
    American88380810001
    CURTIS, Philippa Mary
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    Director
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    United KingdomBritish40995560001
    CURTIS, Philippa Mary
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    Director
    Flat 20 St Hilda's Wharf
    160 Wapping High Street
    E1W 3PG London
    United KingdomBritish40995560001
    DUPERREAULT, Brian
    Paget Hall
    15 Harbour Road
    Paget Pg02
    Bermuda
    Director
    Paget Hall
    15 Harbour Road
    Paget Pg02
    Bermuda
    American75259420003
    DUPERREAULT, Brian
    Sanctuary
    55 Harbour Road
    PG02 Paget
    Bermuda
    Director
    Sanctuary
    55 Harbour Road
    PG02 Paget
    Bermuda
    BermudaU.S. Citizen75259420002
    FIELD, Roger Anthony
    South View
    The Green
    TN11 8QR Leigh
    Kent
    Director
    South View
    The Green
    TN11 8QR Leigh
    Kent
    EnglandBritish101275950001
    FREDERICO, Dominic J
    4 Windy Hollow Road
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    United States
    Director
    4 Windy Hollow Road
    New Hope
    Pennsylvania 18938
    United States
    American75112830001
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Director
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GOODMAN, Leslie David
    19 Tideswell Road
    Putney
    SW15 6LJ London
    Director
    19 Tideswell Road
    Putney
    SW15 6LJ London
    EnglandBritish7683930001
    HAMPTON, Clifford Samuel Herbert
    Marshgate House
    36 Sheen Road
    TW9 1AW Richmond
    Surrey
    Director
    Marshgate House
    36 Sheen Road
    TW9 1AW Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish36483720001
    KENDRICK, Andrew James
    23 Klea Avenue
    SW4 9HG London
    Director
    23 Klea Avenue
    SW4 9HG London
    United KingdomBritish62276900003
    KRAMER, Donald
    1 Beekman Place
    New York 10022
    Usa
    Director
    1 Beekman Place
    New York 10022
    Usa
    Us50057850001
    LANGE, Michael Clemens Anton
    1 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    Director
    1 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    American48641670001
    LLOYD, Jeffrey John
    5 Scotia Building
    Jardine Road
    E1 9WA London
    Director
    5 Scotia Building
    Jardine Road
    E1 9WA London
    British45902540002
    LOSCHERT, William James
    Flat 1
    45 Cadogan Square
    SW1X 0HX London
    Director
    Flat 1
    45 Cadogan Square
    SW1X 0HX London
    United KingdomAmerican51396620001
    POOLE, David Charles, The Lord
    19 Keyes Road
    NW2 3XB London
    Director
    19 Keyes Road
    NW2 3XB London
    United KingdomBritish84127430001
    SCHMALZRIEDT, Gary
    188 East 76th Street
    Penthouse A
    New York 1002
    United States
    Director
    188 East 76th Street
    Penthouse A
    New York 1002
    United States
    American76185280007
    SMITH, Michael Gordon
    9 Fournier Street
    E1 6QE London
    Director
    9 Fournier Street
    E1 6QE London
    British58386920001
    UNDERHILL, Kenneth Landers Hoffman
    Ace Building
    100 Leadenhall Street London
    EC3A 3BP
    Director
    Ace Building
    100 Leadenhall Street London
    EC3A 3BP
    EnglandBritish132498240001
    WILLIAMS, Graham David
    18 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Director
    18 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    British6283470002
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Director designado corporativo
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001760001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CHUBB LONDON GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Leadenhall Street
    EC3A 3BP London
    100
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03600577
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene CHUBB LONDON GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 28 ene 2010
    Entregado el 03 feb 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re ace london group limited. Clients premium account. Account number 90535192.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    Deposit trust deed (third party)(the "trust deed")
    Creado el 22 oct 1997
    Entregado el 12 nov 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All the underwriting obligations of the company incurred by the company as an underwriting member of the society at any time before the termination date 9BEING the 80TH anniversary of the date of the trust deed) including obligations to the society and the trustees (as defined)
    Breve descripción
    All such moneys/other property approved by the council of lloyd's as have been paid or transferred by the depositor or trustees. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871 by the Name of Lloyd's,as Trustees
    Transacciones
    • 12 nov 1997Registro de un cargo (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 27 nov 1996
    Entregado el 09 dic 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge over the deposit being all money in any currency deposited with the bank pursuant to the deposit being:- barclays bank PLC re ace UK limited treasurers sterling bid deposit no 42727855. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 dic 1996Registro de un cargo (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 26 nov 1996
    Entregado el 11 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over deposit
    Creado el 27 mar 1996
    Entregado el 05 abr 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the deed of counter indemnity and/or the guarantee (both as therein defined)
    Breve descripción
    All monies at any time standing to the credit of the account of the company in the books of bank of scotland treasury services PLC together with all interest and other amount accruing on such sums.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 abr 1996Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene CHUBB LONDON GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 sept 2018Inicio de la liquidación
    17 mar 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Neil John Mather
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0