CWC SPVB LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCWC SPVB LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03123060
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CWC SPVB LIMITED?

    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra CWC SPVB LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CWC SPVB LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CACTUSBEAM LIMITED07 nov 199507 nov 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CWC SPVB LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CWC SPVB LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 nov 2015

    Estado de capital el 10 nov 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Russell James John Lyons el 11 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Sir George Iacobescu el 19 oct 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 07 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 nov 2014

    Estado de capital el 25 nov 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 nov 2013

    Estado de capital el 12 nov 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    14 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG04

    Déclaration annuelle établie au 07 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    39 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 07 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Anna Holland como secretario

    2 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario John Raymond Garwood el 23 oct 2009

    3 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de CWC SPVB LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GARWOOD, John Raymond
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Secretario
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    British6767890001
    ANDERSON II, A Peter
    One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Director
    One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    American46038780006
    IACOBESCU, George, Sir
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Director
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    United KingdomBritish42819220002
    LYONS, Russell James John
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    Director
    30th Floor One Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    EnglandBritish81468120002
    HOLLAND, Anna Marie
    137 Cavendish Drive
    Leytonstone
    E11 1DJ London
    Secretario
    137 Cavendish Drive
    Leytonstone
    E11 1DJ London
    British99781150001
    HOSKING, Cherry Lyn
    7 Church Lane
    Deanshanger
    MK19 6HF Milton Keynes
    Northamptonshire
    Secretario
    7 Church Lane
    Deanshanger
    MK19 6HF Milton Keynes
    Northamptonshire
    British127691670001
    PRECIOUS, Martin David
    Bowlers Green House
    SG9 9DE Bowlers Mead
    Hertfordshire
    Secretario
    Bowlers Green House
    SG9 9DE Bowlers Mead
    Hertfordshire
    British104849260001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Director designado
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    ROTHMAN, Gerald
    11 Carlton Hill
    NW8 0JX London
    Director
    11 Carlton Hill
    NW8 0JX London
    UkBritish36855470001
    YOUNG, Charles Bellamy
    Flat B 58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    Director
    Flat B 58 Eaton Square
    SW1W 9BG London
    American35137740002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CWC SPVB LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Canary Wharf Investments Limited
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    One
    England
    06 abr 2016
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AB London
    One
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House, London
    Número de registro2127410
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CWC SPVB LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second fixed and floating charge debenture
    Creado el 27 mar 1997
    Entregado el 11 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The payment and discharge of all liabilities (as defined) in favour of the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including book debts and bank accounts investments goodwill uncalled capital plant and machinery benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • European Investment Bank
    Transacciones
    • 11 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 mar 1997
    Entregado el 11 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined) except for any obligation which, if it were so included would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Breve descripción
    By way of a first legal mortgage the charged property, by way of a first fixed charge all plant and machinery, all moneys standing to the credit of the chargor's receipts account and the debts represented by it, all benefits in respect of the insuarnces, the benefit of all licences, consents and authorisations, the chargor's rights under the development documents trust deed, by way of assignment by way of security, all rental income, any guarantee of rental income contained in or relating to any occupational lease, and any debt owed to the chargor by the borrower, the charged property:-l/h-floors 31-50 (inclusive) and the retail concourse floor one canada square canary wharf london E14 forming part of the building and being the property in the course of registration under t/n-EGL343407. L/h-floor 50 one canada square canary wharf london E14 t/n-EGL323841.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Stanley & Co. International Limited (The "Agent")
    Transacciones
    • 11 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 dic 1996
    Entregado el 03 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to the documentation (as defined) and/or this charge
    Breve descripción
    5 north collonade 10 cabot square canary whsrf including trade and other fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • W&G Lease Finance Limited
    Transacciones
    • 03 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 28 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental charge
    Creado el 20 dic 1996
    Entregado el 09 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys debts obligations and liabilities due or to become due from the company or any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of any finance document (as defined)
    Breve descripción
    By way of legal mortgage all of the cwc real property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • European Investment Bank
    Transacciones
    • 09 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 dic 1996
    Entregado el 03 ene 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the obligor group (as defined) to the chargee under or in connection with the facility agreement dated 27TH december 1995 (as defined) or any other finance document (as defined)
    Breve descripción
    (I) l/hold property known as floor 5(part) north colonnade/10 cabot sq,canary wharf,london E.14 and (ii) l/hold property known as floor 6,5 north colonnade/10 cabot sq,canary wharf,london E.14 with all plant machinery licences consents thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company Limited,as Trustee for the Lenders (As Defined)
    Transacciones
    • 03 ene 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemntal debenture
    Creado el 05 sept 1996
    Entregado el 19 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    And varying the terms of the "core debenture" dated 27TH december 1995
    Breve descripción
    Fixed and floating charges all assets (other than the excluded assets) as defined in form 395 relative to this charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company Limited(As Security Agent)
    Transacciones
    • 19 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 02 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 05 sept 1996
    Entregado el 17 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The liabilities of any member of the obligor group to the facility agent the payment agent bankers trustee company limited (as security agent) any of the lenders and/or any receiver under or in connection with the facility agreement (including without limitation under clause 18.4 of the facility agreement) or under any other finance document and whether existing as at 27TH december 1995 or arising thereafter
    Breve descripción
    L/H property k/a floor 5 (part) 10 cabot square london t/no EGL313097 and all plant and machiery the benefit of all licences property assets undertaking etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company Limited(As Security Agent)
    Transacciones
    • 17 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental charge
    Creado el 30 ago 1996
    Entregado el 17 sept 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever or in connection with any finance document
    Breve descripción
    The property land and premises k/a floor 5 (part) cabot square (formerly k/a parcel FC2) canary wharf london E14 t/n egl 313097 fixed plant and machinery thereon assigns in equity all present and future rights in relation the the property aforesaid. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • European Investment Bank
    Transacciones
    • 17 sept 1996Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 12 jun 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 dic 1995
    Entregado el 16 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All liabilities and obligations due or to become due from any member of the obligor group to the chargees pursuant to the terms of the facility agreementand/or any other finance document (as defined)
    Breve descripción
    All that l/h property ka/ floors 31-50 (inclusive) and the retail concourse floor one canada square canary wharf ondon t/no EGL200721. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company Limited (As Security Agent)
    Transacciones
    • 16 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 02 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second fixed and floating charge debenture
    Creado el 27 dic 1995
    Entregado el 09 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee in any manner whatsoever under or in connection with any finance document (as defined)
    Breve descripción
    By way of legal mortgage,all real property in england and wales including that described in schedule 2,but excluding the lul real property.all that l/h property k/as floors 31-50 (inclusive) and the retail concourse floor,one canada square,canary wharf,london E14.all that l/h property k/as floor 6 cabot square,canary wharf,london E14.t/no.EGL328031 see ch microfiche for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • European Investment Bank
    Transacciones
    • 09 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 30 ene 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 12 jun 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 dic 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0