OFFICE PROPERTIES PL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | OFFICE PROPERTIES PL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03125437 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Dirección de la sede social | Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MWB PROPERTY LIMITED | 01 jul 2008 | 01 jul 2008 |
| MARYLEBONE WARWICK BALFOUR GROUP PLC | 01 jul 1997 | 01 jul 1997 |
| EX-LANDS PROPERTIES PLC | 08 nov 1995 | 08 nov 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2018 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2019 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 oct 2019 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 nov 2019 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 oct 2018 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Ms Joanne Constance Bushell como director el 17 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Wayne David Berger como director el 03 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 jun 2025 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 jun 2024 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Wayne David Berger como director el 31 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Gavin Steven Phillips como director el 31 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Morris como director el 31 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 jun 2023 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 jun 2022 | 17 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 jun 2021 | 20 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2020 | 18 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter David Edward Gibson como director el 28 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 6 Snow Hill London EC1A 2AY a Uhy Hacker Young Llp Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW el 07 oct 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Renuncia de un liquidador | 3 páginas | LIQ06 | ||||||||||
Renuncia de un liquidador | 3 páginas | LIQ06 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 4 páginas | 600 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Burwood Place London W2 2UT England a 6 Snow Hill London EC1A 2AY el 22 jul 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de asuntos | 10 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 oct 2018 con actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2017 | 14 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSHELL, Joanne Constance | Director | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | South Africa | British | 341942760001 | |||||||||
| PHILLIPS, Gavin Steven, Mr. | Director | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | British | 324092780001 | |||||||||
| CAVE, Ian Bruce | Secretario | 392 Woodstock Road OX2 8AF Oxford Oxfordshire | British | 102741680001 | ||||||||||
| CROSSLEY, James Daniel | Secretario | 34 Bellevue Road CM12 9HB Billericay Essex | British | 29059900001 | ||||||||||
| CITY GROUP PLC | Secretario corporativo | City Road EC1Y 2AG London 30 England |
| 35794270004 | ||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| PITSEC LIMITED | Secretario corporativo | Castle Street RG1 7SR Reading 47 England |
| 38734010001 | ||||||||||
| BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Director | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | 34251500001 | |||||||||
| BERGER, Wayne David, Mr. | Director | Quadrant House 4 Thomas More Square E1W 1YW London Uhy Hacker Young Llp | England | Canadian | 323759890001 | |||||||||
| BIBRING, Michael Albert | Director | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | 9320160002 | |||||||||
| BLURTON, Andrew Francis | Director | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 53724380001 | |||||||||
| BOURNE, Graham Alexander | Director | Le Roccabella 24 Avenue Princess Grace Monte Carlo 98000 Monaco | United Kingdom | British | 76871220004 | |||||||||
| BOURNE, Robert Anthony | Director | 100 Cheyne Walk SW10 0DQ London | British | 70526160001 | ||||||||||
| BOUVIER, Alain Charles Patrice | Director | 32 Earls Court Square SW5 9DQ London | England | British | 24106110001 | |||||||||
| BURROW, Robert Philip | Director | 67 Brook Street W1K 4NJ London | England | British | 97252420005 | |||||||||
| CHENERY, Richard James | Director | Lower Slaughter GL54 2HP Cheltenham The Manor Cottage Gloucestershire United Kingdom | England | British | 146075610001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Director | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||||||
| GIBSON, Peter David Edward | Director | Cromac Square BT2 8LA Belfast Forsyth House Northern Ireland | England | British | 235422380001 | |||||||||
| HARRISON, John William | Director | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | 69263980002 | |||||||||
| MARSHALL, David Courtnall | Director | Savannah House 32 Sherwood Road 4051 Durban North South Africa | South Africa | British | 132056360001 | |||||||||
| MORRIS, Richard | Director | Burwood Place W2 2UT London 1 England | England | British | 190653350001 | |||||||||
| MYERSON, Brian Alan | Director | 52 Winnington Road N2 0TY London | British | 63023520001 | ||||||||||
| PARKER, Christopher John | Director | Hill Place Station Road CM8 3JN Wickham Bishops Essex | British | 8218630001 | ||||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Director | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| ROBOTHAM, John Michael | Director | Brickwall Farmhouse Kiln Lane Clophill MK45 4DA Bedford | England | British | 3914540001 | |||||||||
| SANDERSON, Eric Fenton | Director | 10 Harelaw Road EH13 0DR Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 126848980001 | |||||||||
| SHASHOU, Joseph Saleem | Director | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | 51723030002 | |||||||||
| SINGH, Jagtar | Director | West Garden Place Kendal Street W2 2AQ London 1 | United Kingdom | British | 121710890001 | |||||||||
| STARN, William Robert | Director | City Road EC1Y 2AG London 30 | England | American | 154007330001 | |||||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Director designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 | |||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 38524190001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de OFFICE PROPERTIES PL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marley Acquisitions Limited | 11 jul 2017 | Burwood Place W2 2UT London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mwb Serviced Office Holdings Limited (In Liquidation) | 06 abr 2016 | Little New Street EC4A 3TR London Hill House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene OFFICE PROPERTIES PL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over shares | Creado el 01 ago 2008 Entregado el 13 ago 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Entire right, title and interest in and to the 46,951,379 ordinary shares with a nominal value of £0.01 in the capital of mwb business exchange PLC together with all other shares in the capital of mwb business exchange PLC see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 31 mar 2005 Entregado el 14 abr 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 03 jun 2003 Entregado el 16 jun 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all inter-company debts. All the chargor's right, title and interest, present and future, in and to all inter-company debts. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge over shares | Creado el 07 ago 2002 Entregado el 14 ago 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Subordination agreement | Creado el 30 may 2002 Entregado el 10 jun 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Any amounts held on trust for the agent towards the payment of all the senior liabilities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Subordination deed between 140 park lane limited flatford limited and flatford (no.2) limited as the obligors the company and nwb (park lane) limited as original junior creditors and the bank | Creado el 08 ene 2002 Entregado el 18 ene 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A security interest over the "junior liabilities". See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Share charge | Creado el 28 ago 1997 Entregado el 12 sept 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from mwb (warwick road) limited to the chargee in connection with the loan agreement or any security document | |
Breve descripción By way of fixed charge the investments and all dividends interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 05 feb 1996 Entregado el 09 feb 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene OFFICE PROPERTIES PL LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0