FOXMARK (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | FOXMARK (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03130075 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FOXMARK (UK) LIMITED?
- Agencias de publicidad (73110) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra FOXMARK (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Mazars Llp 30 Old Bailey EC4M 7AU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FOXMARK (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| REFLEX MOVE LIMITED | 23 nov 1995 | 23 nov 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FOXMARK (UK) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FOXMARK (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 8 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 sept 2022 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Mazars Llp Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD a C/O Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU el 11 may 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 33 Golden Square London W1F 9JT | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 33 Golden Square London W1F 9JT a Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD el 05 oct 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notification de Clear Channel Overseas Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mar 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Clear Channel International Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mar 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Adam Paul Raymond Tow como director el 04 may 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Byron Kee Chye Hoo como director el 04 may 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Byron Kee Chye Hoo como director el 20 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas James Andrews como director el 20 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nick Andrews como secretario el 20 ene 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FOXMARK (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COCHRANE, Justin Malcolm Brian | Director | 30 Old Bailey EC4M 7AU London C/O Mazars Llp | England | English | 110390650002 | |||||
| TOW, Adam Paul Raymond | Director | 30 Old Bailey EC4M 7AU London C/O Mazars Llp | England | British | 66766420004 | |||||
| ANDREWS, Nick | Secretario | 33 Golden Square London W1F 9JT | British | 109746840001 | ||||||
| CHRISTIAN, Lesley Karen | Secretario | 20 Branston Road Uppingham LE15 9RS Oakham Leicestershire | British | 50767180001 | ||||||
| EMENY, Selina Holliday | Secretario | 16 Priory Road Kew TW9 3DF Richmond Surrey | British | 76404320002 | ||||||
| GODWIN, Timothy Charles William | Secretario | Orchard House 2 Fermoy Court NN7 4JP Little Brington Northamptonshire | British | 75401460001 | ||||||
| GOULBOURNE, David Hugh | Secretario | 9 Victoria Grove SK4 5BU Stockport Cheshire | British | 91875810001 | ||||||
| STEWART, Heather | Secretario | 54 High St West Uppingham LE15 9QD Oakham Leicestershire | British | 56562660001 | ||||||
| KENTMERE ASSOCIATES LIMITED | Secretario designado corporativo | Imperial House 1 Harley Place BS8 3JT Bristol Avon | 900012510001 | |||||||
| ANDREWS, Nicholas James | Director | 33 Golden Square London W1F 9JT | United Kingdom | British | 168572900001 | |||||
| ATKINSON, Robert Nigel | Director | 33 Golden Square London W1F 9JT | United Kingdom | British | 128922360001 | |||||
| BEVAN, Jonathan David | Director | 15 Denning Road Hampstead NW3 1ST London | United Kingdom | British | 110358490001 | |||||
| GODWIN, Timothy Charles William | Director | Orchard House 2 Fermoy Court NN7 4JP Little Brington Northamptonshire | United Kingdom | British | 75401460001 | |||||
| GOULBOURNE, David Hugh | Director | 9 Victoria Grove SK4 5BU Stockport Cheshire | England | British | 91875810001 | |||||
| HOO, Byron Kee Chye | Director | 33 Golden Square London W1F 9JT | England | British | 214640470001 | |||||
| JONES, Graeme Andrew | Director | Oak Tree Cottage 1 Langley Common Road Barkham RG40 4TU Wokingham Berkshire | British | 57076170001 | ||||||
| LAURENCE, Robert | Director | 29 Saint Johns Avenue SW15 6AL London | British | 84494070001 | ||||||
| OLIVER, David Henry Maxwell | Director | 33 Golden Square London W1F 9JT | United Kingdom | British | 67052550001 | |||||
| SPRING, Stephanie | Director | Courtnell Street W2 5BX London 34 | England | British | 102849950001 | |||||
| TAIT, Philip | Director | Great Eastern Villa 101 Brooke Road LE15 6HQ Oakham Leicestershire | British | 33937620002 | ||||||
| LAMBTON LIMITED | Director designado corporativo | Imperial House 1 Harley Place BS8 3JT Bristol Avon | 900012500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FOXMARK (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Channel Overseas Limited | 03 mar 2021 | Golden Square W1F 9JT London 33 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Clear Channel International Limited | 23 nov 2016 | Golden Square W1F 9JT London 33 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene FOXMARK (UK) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment by way of charge | Creado el 01 jun 2000 Entregado el 10 jun 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date | |
Breve descripción All payments due under two separate agreements dated 14 may 1999 and 19 october A999. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 01 jun 2000 Entregado el 10 jun 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a loan facility agreement of even date | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge and security assignment | Creado el 23 dic 1998 Entregado el 06 ene 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for itself and the investors (as defined)) | |
Breve descripción Assignment of all right title and interest in and to all payments due under all present and future agreements by which the company grants leases or licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 dic 1998 Entregado el 06 ene 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent for itself and the investors (as defined)) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene FOXMARK (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0