LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03131738 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de sociedades holding de distribución (64204) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | 101 Linkfield Street RH1 6BY Redhill |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
AMRESCO UK HOLDINGS LIMITED | 24 ene 1996 | 24 ene 1996 |
COILSTAT LIMITED | 28 nov 1995 | 28 nov 1995 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Jeremy John Robinson el 15 ago 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 nov 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Cavendish House 233-235 High Street Guildford Surrey GU1 6BJ a 101 Linkfield Street Redhill RH1 6BY el 27 dic 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Jeremy John Robinson el 14 dic 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 08 nov 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan | Secretario | 101 Linkfield Street RH1 6BY Redhill Surrey | British | Asset Manager | 92059070002 | |||||
ROBINSON, Jeremy John | Director | Linkfield Street RH1 6BY Redhill 101 England | England | British | Manager | 92059060014 | ||||
ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan | Director | 101 Linkfield Street RH1 6BY Redhill Surrey | England | British | Asset Manager | 92059070002 | ||||
HOLMES, Andrew Dominic | Secretario | 34 Hill Road Borstal ME1 3NN Rochester Kent | British | 48442930001 | ||||||
MACK, John | Secretario | 20 St Mary's Avenue RG26 5UU Bramley Hampshire | British | 94773940001 | ||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
NQH (CO SEC) LIMITED | Secretario corporativo | Third Floor Narrow Quay House Prince Street BS1 4AH Bristol Avon | 75423270001 | |||||||
ADAIR III, Robert Lafayette | Director | 700 North Pearl Street Suite 2400 Dallas Texas 75201 America | American | President Of Amresco | 46407640003 | |||||
BENSON, Mark Paul | Director | Pantiles Copt Hill, Danbury CM3 4NN Chelmsford Essex | England | English | Investment Management | 95759080001 | ||||
CLARK, Charles Edward | Director | 2516 Selwyn Avenue Charlotte North Carolina 28209 United States Of America | American | Director | 46148890002 | |||||
HOLMES, Andrew Dominic | Director | 34 Hill Road Borstal ME1 3NN Rochester Kent | British | Accountant | 48442930001 | |||||
LUTZ (JUNIOR), Robert Harold | Director | 700 North Pearl Street Suite 2400 Dallas Texas 75201-7424 America | American | Chairman Of The Board | 61566980001 | |||||
PARFITT, Stuart Howard | Director | 42 Chiswick Staithe Hartington Road W4 3TP London | British | Investment Management | 58854160001 | |||||
URQUHART, Douglas Russell | Director | 700 N Pearl Suite 2400 Dallas Texas 75201 Usa | British | Senior Vice President | 45191680001 | |||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Jeremy John Robinson | 06 abr 2016 | Farnham Road Holt Pound GU10 4LE Farnham Rectory Cottage England | No |
Nacionalidad: English País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Matthew Robert Stefan Royer-Kennedy | 06 abr 2016 | Linkfield Street RH1 6BY Redhill 101 | No |
Nacionalidad: English País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
|
¿Tiene LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Share pledge agreement registered under 398(2) (due diligence) of the companies act 1985 | Creado el 15 sept 2003 Entregado el 07 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The entire issue share capital of erste leadenhall deutschland gmbh, consisting of one fully paid share in the nominal amount of DM50,000 together with all present and future dividends and profits deriving therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 09 sept 2003 Entregado el 16 sept 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee or the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 22 mar 2000 Entregado el 31 mar 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due or to become due from the company or any of the other chargors (as defined) to each finance party (as defined) under or pursuant to each finance document (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Pledge of shares contained in an amendment and supplement to stock pledge agreement | Creado el 18 ene 2000 Entregado el 03 feb 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with an amended and restated credit agreement dated on or about 18 january 2000 amending and restating the credit agreement dated 12 august 1998 as modified, amended, supplemented and/or restated from time to time, the stock pledge or otherwise howsoever | |
Breve descripción All shares in amresco retail ventures I limited, amresco retail ventures ii limited and five other companies listed and all dividends etc in respect thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Pledge of shares contained in a supplement iii to loan documents | Creado el 21 dic 1999 Entregado el 07 ene 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a credit agreement dated 12 august 1998 | |
Breve descripción All shares in amresco retail ventures I limited,amresco retail ventures ii limited and five other companies listed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 25 jul 1996 Entregado el 13 ago 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All obligations due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for otself and the other financial institutions (as defined) which are parties to the facility agreement (as defined) or other loan documents (as defined) | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creado el 07 jun 1996 Entregado el 27 jun 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to nationsbank of texas, N.A. (the agent for itself and other financial institutions which are parties, either originally or otherwise, to the facility agreement) under the facility agreement or other loan documents (as defined in the facility agreement dated 25TH april 1996) | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0