LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED

LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03131738
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de sociedades holding de distribución (64204) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AMRESCO UK HOLDINGS LIMITED24 ene 199624 ene 1996
    COILSTAT LIMITED28 nov 199528 nov 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    It was resolved that the accounts be and are hereby adopted 08/11/2017
    RES13

    Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Jeremy John Robinson el 15 ago 2015

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 dic 2015

    Estado de capital el 29 dic 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 dic 2014

    Estado de capital el 27 dic 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de Cavendish House 233-235 High Street Guildford Surrey GU1 6BJ a 101 Linkfield Street Redhill RH1 6BY el 27 dic 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 dic 2013

    Estado de capital el 25 dic 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Jeremy John Robinson el 14 dic 2011

    2 páginasCH01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Approve sale of share capital of plt LTD 31/10/2011
    RES13

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de autoridad para comprar un número de acciones

    RES09

    Estado de capital el 08 nov 2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    ¿Quiénes son los directivos de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    Secretario
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    BritishAsset Manager92059070002
    ROBINSON, Jeremy John
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    England
    Director
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    England
    EnglandBritishManager92059060014
    ROYER KENNEDY, Matthew Robert Stefan
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    Director
    101 Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    Surrey
    EnglandBritishAsset Manager92059070002
    HOLMES, Andrew Dominic
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    Secretario
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    British48442930001
    MACK, John
    20 St Mary's Avenue
    RG26 5UU Bramley
    Hampshire
    Secretario
    20 St Mary's Avenue
    RG26 5UU Bramley
    Hampshire
    British94773940001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    Secretario corporativo
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    75423270001
    ADAIR III, Robert Lafayette
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201
    America
    Director
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201
    America
    AmericanPresident Of Amresco46407640003
    BENSON, Mark Paul
    Pantiles
    Copt Hill, Danbury
    CM3 4NN Chelmsford
    Essex
    Director
    Pantiles
    Copt Hill, Danbury
    CM3 4NN Chelmsford
    Essex
    EnglandEnglishInvestment Management95759080001
    CLARK, Charles Edward
    2516 Selwyn Avenue
    Charlotte
    North Carolina
    28209
    United States Of America
    Director
    2516 Selwyn Avenue
    Charlotte
    North Carolina
    28209
    United States Of America
    AmericanDirector46148890002
    HOLMES, Andrew Dominic
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    Director
    34 Hill Road
    Borstal
    ME1 3NN Rochester
    Kent
    BritishAccountant48442930001
    LUTZ (JUNIOR), Robert Harold
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201-7424
    America
    Director
    700 North Pearl Street
    Suite 2400
    Dallas
    Texas 75201-7424
    America
    AmericanChairman Of The Board61566980001
    PARFITT, Stuart Howard
    42 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    Director
    42 Chiswick Staithe
    Hartington Road
    W4 3TP London
    BritishInvestment Management58854160001
    URQUHART, Douglas Russell
    700 N Pearl Suite 2400
    Dallas
    Texas
    75201
    Usa
    Director
    700 N Pearl Suite 2400
    Dallas
    Texas
    75201
    Usa
    BritishSenior Vice President45191680001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Jeremy John Robinson
    Farnham Road
    Holt Pound
    GU10 4LE Farnham
    Rectory Cottage
    England
    06 abr 2016
    Farnham Road
    Holt Pound
    GU10 4LE Farnham
    Rectory Cottage
    England
    No
    Nacionalidad: English
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    Mr Matthew Robert Stefan Royer-Kennedy
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    06 abr 2016
    Linkfield Street
    RH1 6BY Redhill
    101
    No
    Nacionalidad: English
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene LEADENHALL UK HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Share pledge agreement registered under 398(2) (due diligence) of the companies act 1985
    Creado el 15 sept 2003
    Entregado el 07 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The entire issue share capital of erste leadenhall deutschland gmbh, consisting of one fully paid share in the nominal amount of DM50,000 together with all present and future dividends and profits deriving therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Oval (1878) Limited
    Transacciones
    • 07 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 sept 2003
    Entregado el 16 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Oval (1878) Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 16 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 mar 2000
    Entregado el 31 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company or any of the other chargors (as defined) to each finance party (as defined) under or pursuant to each finance document (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nationwide Building Society,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 31 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 sept 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of shares contained in an amendment and supplement to stock pledge agreement
    Creado el 18 ene 2000
    Entregado el 03 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with an amended and restated credit agreement dated on or about 18 january 2000 amending and restating the credit agreement dated 12 august 1998 as modified, amended, supplemented and/or restated from time to time, the stock pledge or otherwise howsoever
    Breve descripción
    All shares in amresco retail ventures I limited, amresco retail ventures ii limited and five other companies listed and all dividends etc in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, N.A.
    Transacciones
    • 03 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of shares contained in a supplement iii to loan documents
    Creado el 21 dic 1999
    Entregado el 07 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a credit agreement dated 12 august 1998
    Breve descripción
    All shares in amresco retail ventures I limited,amresco retail ventures ii limited and five other companies listed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America,N.A.
    Transacciones
    • 07 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 25 jul 1996
    Entregado el 13 ago 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for otself and the other financial institutions (as defined) which are parties to the facility agreement (as defined) or other loan documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nationsbank of Texas N.A.
    Transacciones
    • 13 ago 1996Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 07 jun 1996
    Entregado el 27 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to nationsbank of texas, N.A. (the agent for itself and other financial institutions which are parties, either originally or otherwise, to the facility agreement) under the facility agreement or other loan documents (as defined in the facility agreement dated 25TH april 1996)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nationsbank of Texas, N.A. (The "Agent")
    Transacciones
    • 27 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0