CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03132440 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 01 feb 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 10 páginas | 600 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 10 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 sept 2022 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephanus Christiaan Van Waalkwijk Van Doorn como director el 01 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 5 Churchill Place 10th Floor London E14 5HU | 2 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 5 Churchill Place 10th Floor London E14 5HU | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Churchill Place 10th Floor London E14 5HU England a 1 More London Place London SE1 2AF el 11 oct 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Paul Mayes como director el 30 sept 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Churchill Place 10th Floor London E14 5HP England a 5 Churchill Place 10th Floor London E14 5HU el 16 sept 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Csc Corporate Services (Uk) Limited como secretario el 06 sept 2021 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Mayes como secretario el 06 sept 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Staples Uk Ltd Hampden Court Kingsmead Business Park Frederick Place High Wycombe Buckinghamshire HP11 1JU a 5 Churchill Place 10th Floor London E14 5HP el 10 sept 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Annette Karina Den Bak - Maas como director el 30 ago 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephanus Christiaan Van Waalkwijk Van Doorn como director el 30 ago 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Celina Herman Henckaers como director el 27 ago 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 01 feb 2020 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 02 feb 2019 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 03 feb 2018 | 19 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Churchill Place 10th Floor E14 5HP London 5 England |
| 239196070001 | ||||||||||
| DEN BAK - MAAS, Annette Karina | Director | Hoogoorddreef Amsterdam 62 1101 Be Netherlands | Netherlands | Dutch | 286856880001 | |||||||||
| BLUNT, Claire Jacqueline | Secretario | Nugents Park HA5 4RA Hatch End Reynolds Middlesex | British | 179667220001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, Michael Ernest Courtney | Secretario | 50 Clarence Road Four Oaks B74 4AQ Sutton Coldfield West Midlands | British | 108885660001 | ||||||||||
| GUEST, Sarah Elizabeth | Secretario | Tameside Drive Holford B6 7AY Birmingham West Midlands | 156908690001 | |||||||||||
| MADDEN, Thomas | Secretario | Greenacre Preston Fields B95 5EQ Henley In Arden West Midlands | British | 76997270001 | ||||||||||
| MAYES, Steven | Secretario | Churchill Place 10th Floor E14 5HP London 5 England | 254847610001 | |||||||||||
| SIGLEY, Caroline | Secretario | 14 Willow Close Spratton NN6 8JH Northampton Northamptonshire | British | 66259630001 | ||||||||||
| SLEVIN, Damian | Secretario | c/o Staples Uk Ltd Kingsmead Business Park Frederick Place HP11 1JU High Wycombe Hampden Court Buckinghamshire England | 185152180001 | |||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| MUNDAYS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Crown House Church Road Claygate KT10 0LP Esher Surrey | 41120340001 | |||||||||||
| BIRKS, Peter | Director | Tameside Drive Holford B6 7AY Birmingham Corporate Express Limited Uk | United Kingdom | British | 133139730003 | |||||||||
| BLUNT, Claire Jacqueline | Director | Nugents Park HA5 4RA Hatch End Reynolds Middlesex | Uk | British | 179667220001 | |||||||||
| CAPEL, Manon Barbara Antoinette | Director | c/o Staples Uk Ltd Kingsmead Business Park Frederick Place HP11 1JU High Wycombe Hampden Court Buckinghamshire England | Netherlands | Dutch | 161716150001 | |||||||||
| CULLEN, Roderick Leonard Dunlop | Director | 8 Heath Drive SM2 5RP Sutton Surrey | United Kingdom | United Kingdom | 43185950001 | |||||||||
| DODSON, Michael William | Director | Spinney Close Shadow Brook Lane B92 0DG Solihull | British | 97251530001 | ||||||||||
| DOWNES, Jason Jonathan | Director | Tameside Drive Holford B6 7AY Birmingham West Midlands | England | British | 158928220001 | |||||||||
| DOYLE, Aidan Michael | Director | c/o Staples Uk Ltd Kingsmead Business Park Frederick Place HP11 1JU High Wycombe Hampden Court Buckinghamshire England | Ireland | Irish | 156851850001 | |||||||||
| FRANK, Thomas Edward | Director | Mill Farm Wing Guildford Road GU6 8LB Cranleigh Surrey | American | 61203030002 | ||||||||||
| GUEST, Sarah Elizabeth | Director | Tameside Drive Holford B6 7AY Birmingham West Midlands | England | British | 158967330001 | |||||||||
| HENCKAERS, Michael Celina Herman | Director | c/o Staples Uk Ltd Kingsmead Business Park Frederick Place HP11 1JU High Wycombe Hampden Court Buckinghamshire | Belgium | Belgian | 246059940001 | |||||||||
| HENNEBELLE, Vianney Paul | Director | c/o Staples Uk Ltd Kingsmead Business Park Frederick Place HP11 1JU High Wycombe Hampden Court Buckinghamshire | France | French | 237979620001 | |||||||||
| JONES, Dylan Glynn | Director | Stone Barn Wakerley LE15 8PA Oakham Leicestershire | England | British | 153523810001 | |||||||||
| LANDIS, Lissa Jean | Director | c/o Staples Uk Ltd Kingsmead Business Park Frederick Place HP11 1JU High Wycombe Hampden Court Buckinghamshire England | England | French | 239729050001 | |||||||||
| MACALUSO, Brian James | Director | 24 Lady Byron Lane Knowle B93 9AU Solihull | British | 93684880003 | ||||||||||
| MADDEN, Thomas | Director | Greenacre Preston Fields B95 5EQ Henley In Arden West Midlands | British | 76997270001 | ||||||||||
| MAYES, Steven Paul | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | United Kingdom | British | 235008580001 | |||||||||
| MILLETT JNR, Richard Leonard | Director | 487 South Pontiac Way Denver Colorado FOREIGN Usa 80224 | American | 45696310001 | ||||||||||
| MORGAN, Paul | Director | Bostock House Broadlands NN6 9AZ Pitsford Northampton | British | 85893350001 | ||||||||||
| MUNDAY, Peter James | Director | Pinewood Lodge Warren Lane KT22 0ST Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 44005460001 | |||||||||
| PECK, Raymond Charles | Director | 62 Parchment Street SO23 8BA Winchester Hampshire | British | 12659920002 | ||||||||||
| ROBERTSON, Martin Asher | Director | Tameside Drive Holford B6 7AY Birmingham West Midlands | England | American | 173482510001 | |||||||||
| ROBINSON, Bruce | Director | 2 Invicta Cottages Roestock Lane, Colney Heath AL4 0QW St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 147379870001 | |||||||||
| ROGERS, Derek Robert | Director | Woodgetters Shipley Road, Southwater RH13 7BQ Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 63550400001 | |||||||||
| SOMERVILLE, Andy Forbes | Director | Robin Hill London Road HP8 4NQ Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 200512970001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Express Uk Holding Limited | 06 abr 2016 | Kingsmead Business Park Frederick Place HP11 1JU High Wycombe Hampden Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 02 may 2000 Entregado el 19 may 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent) under the credit agreement and the debenture and the lenders party from time to time to the credit agreement (as defined) under (I) the credit agreement and (ii) the subsidiaries guaranty dated as of 216TH october 1999 | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 09 may 1997 Entregado el 15 may 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CORPORATE EXPRESS (HOLDINGS) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0