ATKINS & CRIPPS LIMITED

ATKINS & CRIPPS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaATKINS & CRIPPS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03140130
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    UHY HACKER YOUNG LLP
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    EW1 YW London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    YANKEE LIMITED15 dic 199515 dic 1995

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 may 2011

    7 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Kemp House Cumnor Hill Oxford Oxfordshire OX2 9PH el 14 dic 2010

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 24 nov 2010

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2010

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 15 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 ene 2010

    Estado de capital el 11 ene 2010

    • Capital: GBP 3,200,001
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2009

    3 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    17 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    19 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    resolution

    Acuerdo electivo

    ELRES

    legacy

    3 páginas363a

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asistencia financiera para la adquisición de acciones

    RES07

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    1 páginas225

    ¿Quiénes son los directivos de ATKINS & CRIPPS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Secretario
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    English15662110002
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Director
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    FINEMAN, Simon
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    Director
    1 Farndon Road
    OX2 6RS Oxford
    EnglandBritish61133550002
    DAVIES, Gareth
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secretario
    Adams Gate
    Mallows Green Road, Manuden
    CM23 1DG Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British71865070001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Secretario
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    British50701840001
    PHILLIPS, Lawrence Stephen
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Secretario
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British11800250003
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Secretario designado corporativo
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    BARRINGER, Paul Brandon
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    Director
    11 Longstreet Road
    27890 Weldon
    Nc
    United States Of America
    American34440990001
    BARRINGER, Victor
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    Director
    PO BOX 829
    Green Street Extension
    Weldon
    North Carolina 27890
    American50712820003
    BOSTON, Neil Moir, Mr.
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    12 North Quay
    OX14 5RY Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish113486000001
    CAMPOLL, Henry William
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    Director
    105 Joelene Court
    Rocky Mount
    North Carolina 27803
    Usa
    American54149770001
    CONGER, Stephen Halsey
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    Director
    Box 829
    NC 27890 Weldon
    North Carolina
    American47437230001
    DOBSON, John William
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    Director
    Japonica Cottage Blacksmith Lane
    Charlton On Otmoor
    OX5 2UH Kidlington
    Oxfordshire
    EnglandEnglish15662110002
    GORMAN, James John Stuart
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    Director
    2 Lime Meadows
    Sewards End
    CB10 2LQ Saffron Walden
    Essex
    British47435900001
    HAYWOOD, David James
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    Director
    Blackberry Cottage
    Turnpike Hill Withersfield
    CB9 7RY Haverhill
    Suffolk
    United KingdomBritish47436450002
    HIPKIN, Ian Robert
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    1 Van Gogh Place
    St Ives
    PE27 3HE Huntingdon
    Cambridgeshire
    British78621800001
    MARRIOTT, Duncan Peter
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    Director
    Grange Farm 85 The Row
    Sutton
    CB6 2PB Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritish50701840001
    MCGAGIN, Timothy A
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Director
    201 Candlewood Road
    Rocky Mount
    North Carolina
    27804
    United States Of America
    Usa40432680002
    SEAY, Ronald Frederick
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    Director
    21 Pumpkin Lane
    NC 27850 Littleton
    North Carolina
    America
    American47437050001
    THEWLIS, Clive Roger
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    Director
    8 Harolds Close
    Leafield
    OX29 9PU Witney
    Oxfordshire
    EnglandBritish125543430001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Director designado corporativo
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    ¿Tiene ATKINS & CRIPPS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 29 sept 2006
    Entregado el 07 oct 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 oct 2006Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 28 ene 2005
    Entregado el 01 feb 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Units 50-54, lancaster way, ely, cambridgeshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 feb 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 27 feb 2004
    Entregado el 04 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 07 sept 2000
    Entregado el 13 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 07 sept 2000
    Entregado el 13 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property k/a 95 london road bishops stortford t/n HD316227. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 07 feb 2000
    Entregado el 10 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein
    Breve descripción
    All the company's right title benefit and interest in and to the deposit of £6,500 held in an interest bearing deposit account in accordance with the deed.
    Personas con derecho
    • Southend Property Management Limited
    Transacciones
    • 10 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 07 feb 2000
    Entregado el 10 feb 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £6,500 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Units 1 & 2 tamar view industrial estate saltash.
    Personas con derecho
    • Southend Property Management Limited
    Transacciones
    • 10 feb 2000Registro de un cargo (395)
    • 22 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 03 abr 1997
    Entregado el 04 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £13,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the deed
    Breve descripción
    By way of legal charge the sum of £13,000 or such other monies held from time to time pursuant to the deed.
    Personas con derecho
    • Southend Property Management Limited
    Transacciones
    • 04 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 ene 1996
    Entregado el 09 feb 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Breve descripción
    L/H-property k/a sheffield park sawmills uckfield east sussex. F/h-unit 5 bilston industrial estate bilston west midlands t/n-WM421694. F/h-95 london road bishop's stortford t/n-HD316227. F/h-9 burrington way plymouth t/n-DN241029. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Coastal Lumber Company
    Transacciones
    • 09 feb 1996Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture created by the company formerly known as yankee limited
    Creado el 22 ene 1996
    Entregado el 26 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The First National Bank of Boston
    Transacciones
    • 26 ene 1996Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ATKINS & CRIPPS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 nov 2010Inicio de la liquidación
    01 oct 2011Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Profesional
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Profesional
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0