THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 03142762 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
- Educación secundaria técnica y profesional (85320) / Educación
- Otra educación n.c.p. (85590) / Educación
¿Dónde se encuentra THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Adcroft Hilton 269 Church Street FY1 3PB Blackpool |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores | 14 páginas | LIQ14 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 mar 2022 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 24 mar 2021 | 12 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Appleby Goods Shed Station Yard Appleby in Westmorland Cumbria CA16 6UL a Adcroft Hilton 269 Church Street Blackpool FY1 3PB el 21 abr 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de asuntos | 10 páginas | LIQ02 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Mc Darren como director el 16 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2019 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 9 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Caldwell como director el 01 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2018 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Malcolm Preston como director el 30 nov 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2017 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas Guy Mills como director el 30 nov 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Janet Ailsa Hartley como director el 01 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Maxwell Keetley como director el 01 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ago 2016 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2016 au 31 ago 2016 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVIETY, Alan | Secretario | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | British | 1714060001 | ||||||
| CALDWELL, John | Director | Hilton CA16 6LU Appleby-In-Westmorland Swindale House United Kingdom | United Kingdom | British | 254965880001 | |||||
| COLLINSON, William Gibson | Director | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | England | British | 140754300002 | |||||
| HARTLEY, Janet Ailsa | Director | Home Farm Buildings CA17 4AP Kirkby Stephen Out Of Eden Eden Cumbria United Kingdom | England | British | 46963080005 | |||||
| MC DARREN, John | Director | Hilton CA16 6LU Appleby-In-Westmorland Fair View England | England | British | 266921600001 | |||||
| MCVIETY, Alan | Director | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | England | British | 1714060001 | |||||
| ROSTRON, Jonathan | Director | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | United Kingdom | English | 127918960001 | |||||
| WOOFF, Eric Stanley Charles | Director | 269 Church Street FY1 3PB Blackpool Adcroft Hilton | United Kingdom | British | 44610730001 | |||||
| ALGIE, Tom Howard | Secretario | Hillfoot Barn Selside BD24 0HZ Settle North Yorkshire | British | 45794310002 | ||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Secretario designado corporativo | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| ALGIE, Tom Howard | Director | Hillfoot Barn Selside BD24 0HZ Settle North Yorkshire | British | 45794310002 | ||||||
| BARTON, John Michael | Director | Haverbrack House LA7 7AH Milnthorpe Cumbria | British | 64425490002 | ||||||
| BENDELOW, Victor Carl | Director | Old School Long Marton CA16 6JP Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 2487670001 | |||||
| CLARK, Robert Lawrence | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | United Kingdom | British | 2770530001 | |||||
| COULTHARD, Leonard | Director | Chapel House Milburn CA10 1TW Penrith Cumbria | England | British | 66835790002 | |||||
| GRAHAM, Duncan Gilmour | Director | Parkburn Colby CA16 6BD Appleby Cumbria | British | 91888120001 | ||||||
| HAYES, Gareth, Dr | Director | 2 Keith Grove Appleby CA16 6XR Cumbria | British | 92840510001 | ||||||
| HOUSTON, Ruth Jane | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 157297690001 | |||||
| JOHNSON, Stephen | Director | Wetheriggs Lane CA11 8NG Penrith Ullswater Community College Cumbria United Kingdom | United Kingdom | British | 96329550001 | |||||
| KEETLEY, David Maxwell | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | United Kingdom | British | 147692860001 | |||||
| LANGAN, Ella, Councillor | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Cumbria | British | 95604180001 | |||||
| LANGAN, Ella, Councillor | Director | Kambrela Colby CA16 6BD Appleby Cumbria | Cumbria | British | 95604180001 | |||||
| MILLS, Nicholas Guy | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 157297680001 | |||||
| PACKWOOD, Christopher Francis Harmon | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 83153260001 | |||||
| PATTERSON, Clare | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 102861750001 | |||||
| PORTER, John Eric | Director | Brook House Upton Caldbeck CA7 8EU Wigton Cumbria | United Kingdom | British | 38463950001 | |||||
| PRESTON, Stephen Malcolm | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 66836630001 | |||||
| RHODES, Alexander | Director | The Cottage Croft Ends CA16 6JW Appleby In Westmorland Cumbria | British | 110015210001 | ||||||
| SCOTT, Keith Watson | Director | Appleby Goods Shed Station Yard CA16 6UL Appleby In Westmorland Cumbria | Great Britain | British | 110971270001 | |||||
| SPENCE, Archie Campbell | Director | 14 Hothfield Drive CA16 6HJ Appleby In Westmorland Cumbria | England | British | 66836110001 | |||||
| WILSON, Jennifer | Director | 4 Scaur Close Lazonby CA10 1BT Penrith Cumbria | British | 39719270001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 02 ene 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 02 mar 2010 Entregado el 05 mar 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene THE APPLEBY HERITAGE CENTRE LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0