SHELFCO 1235 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHELFCO 1235 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03148337
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHELFCO 1235 LIMITED?

    • otras impresiones (18129) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra SHELFCO 1235 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2/3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHELFCO 1235 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GEMINI BRIGHTON LIMITED30 abr 201330 abr 2013
    ANDUS PRINT LIMITED19 ene 199619 ene 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHELFCO 1235 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHELFCO 1235 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    19 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2019

    19 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2017

    22 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2018

    20 páginasLIQ03

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 27 mar 2015

    LRESEX

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.18

    10 páginas4.20

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2016

    20 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de Unit a1 Dolphin Way Shoreham by Sea West Sussex BN43 6NZ a 2/3 Pavilion Buildings Brighton East Sussex BN1 1EE el 13 abr 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Cese del nombramiento de David John Britton como director el 20 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Boyle como director el 20 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 mar 2015

    Estado de capital el 10 mar 2015

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ene 2014

    16 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 jul 2013

    16 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed gemini brighton LIMITED\certificate issued on 14/05/14
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name14 may 2014

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 06 may 2014

    RES15
    change-of-name14 may 2014

    Cambio de nombre por resolución

    NM01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 jul 2014 au 31 ene 2014

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 abr 2014

    Estado de capital el 14 abr 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2013 au 31 jul 2013

    1 páginasAA01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed andus print LIMITED\certificate issued on 30/04/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name30 abr 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 07 mar 2013

    RES15
    change-of-name30 abr 2013

    Cambio de nombre por resolución

    NM01

    Déclaration annuelle établie au 19 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2012

    16 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2011

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SHELFCO 1235 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JONES, Owen
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    Secretario
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    165864810001
    CROPPER, Stephen Andrew
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    Director
    Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    2/3
    East Sussex
    EnglandBritish38816830003
    HOLMES, Emma
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    Secretario
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    British48967630002
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Secretario
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    British24756150004
    STARTCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    Secretario designado corporativo
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    900009720001
    BOYLE, John
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    Director
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    United KingdomBritish141437280001
    BRAZIER, Lynn Suzanne
    34 Rose Walk
    Goring By Sea
    BN12 4AU Worthing
    West Sussex
    Director
    34 Rose Walk
    Goring By Sea
    BN12 4AU Worthing
    West Sussex
    British59230810001
    BRITTON, David John
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    Director
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    EnglandBritish68594390004
    HOLMES, Emma
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    Director
    Flat 2 59 Sackville Road
    BN3 3WD Hove
    East Sussex
    British48967630002
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Director
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    EnglandBritish24756150004
    KELLY, Ryan
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    Director
    Unit A1
    Dolphin Way
    BN43 6NZ Shoreham By Sea
    West Sussex
    United KingdomBritish152024020001
    NEWCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    Director designado corporativo
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    900009710001

    ¿Tiene SHELFCO 1235 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debentures
    Creado el 27 ene 2011
    Entregado el 29 ene 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Centric Spv 1 Limited
    Transacciones
    • 29 ene 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 20 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 30 jul 2008
    Entregado el 08 ago 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 08 ago 2008Registro de un cargo (395)
    • 14 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    All assets debenture
    Creado el 05 mar 2007
    Entregado el 07 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 07 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage deed
    Creado el 01 feb 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a 47 highcroft villas brighton east sussex t/no's;-ESX33813 and ESX88672. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 dic 1998
    Entregado el 19 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • G E Capital Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 19 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Creado el 24 abr 1996
    Entregado el 08 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement (as defined therein) or otherwise
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge (I) all debts, the subject of an agreement between the company and the chargee (ii) all other debts owing to the company and (iii) all rights in favour of the company related to or arising under any contract of sale giving rise to any such debt. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Venture Factors Limited
    Transacciones
    • 08 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 28 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 10 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 11 jun 1997Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 17 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 mar 1996
    Entregado el 05 abr 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    47 highcroft villas brighton t/nos: ESX33813 and ESX88672. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 abr 1996Registro de un cargo (395)
    • 17 jun 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SHELFCO 1235 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 mar 2015Inicio de la liquidación
    14 jun 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jonathan James Beard
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Profesional
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    John Walters
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex
    Profesional
    2-3 Pavilion Buildings
    BN1 1EE Brighton
    East Sussex

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0