TP GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TP GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03152034 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TP GROUP LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TP GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Harston Mill Royston Road Harston CB22 7GG Cambridge England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TP GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TP GROUP PLC | 02 jun 2015 | 02 jun 2015 |
| CORAC GROUP PLC | 29 ene 1996 | 29 ene 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TP GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TP GROUP LIMITED?
| Última declaración de confirmación | |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 16 ago 2025 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TP GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripci ón | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 031520340013 | 1 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 031520340014 | 1 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 031520340015 | 1 páginas | MR05 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 11 sept 2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 031520340013, creada el 18 mar 2025 | 42 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 031520340014, creada el 18 mar 2025 | 62 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Registro de la carga 031520340015, creada el 18 mar 2025 | 37 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Miss Sarah Elizabeth Cole el 09 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 ago 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 33 páginas | AA | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 031520340008 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 031520340012 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Cale House Station Road Wincanton BA9 9FE England a Harston Mill Royston Road Harston Cambridge CB22 7GG el 06 nov 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 71 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 16 ago 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Cale House Station Road Wincanton BA9 9FE | 1 páginas | AD04 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Derren Mark Stroud como director el 31 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Derren Mark Stroud como secretario el 31 may 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TP GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETT, Jonathan | Director | Royston Road Harston CB22 7GG Cambridge Harston Mill England | England | British | 204193690001 | |||||
| COLE, Sarah Elizabeth | Director | Royston Road Harston CB22 7GG Cambridge Harston Mill England | England | British | 158070400004 | |||||
| BANNER, Paul Lancelot | Secretario | Cherry Trees 43 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | British | 142808820001 | ||||||
| CRAWFORD, Mark Stephen | Secretario | Kingston Lane UB8 3PQ Uxbridge Brunel Science Park Middlesex | British | 147127700001 | ||||||
| DAVENHILL, Michael Frederick | Secretario | Flat 31 79 Gloucester Street SW1V 4EA London | British | 33959920001 | ||||||
| HARROW, Stephen Giles | Secretario | 683-685 Stirling Road SL1 4ST Slough Technology Centre Berkshire | British | 161693170001 | ||||||
| HEWLETT, Anthony Michael | Secretario | Camperdown Sycamore Road HP6 6BB Amersham Buckinghamshire | British | 97414960001 | ||||||
| IVINGS, Thomas Edwin | Secretario | 58 Manor Road OX20 1XJ Woodstock Oxfordshire | British | 59703880002 | ||||||
| MACPHERSON, Claire Louise, Ms. | Secretario | Station Road BA9 9FE Wincanton Cale House England | 194920370001 | |||||||
| MILES, Roberta Caroline | Secretario | 11 Woodlands Chesterton OX26 1TN Bicester Oxfordshire | British | 39473610002 | ||||||
| NEWELL, Philip | Secretario | 24 Hill Rise Chalfont St Peter SL9 9BH Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 93959210001 | ||||||
| STROUD, Derren Mark | Secretario | Station Road BA9 9FE Wincanton Cale House England | 295339890001 | |||||||
| WEBB, Michael John | Secretario | 683-685 Stirling Road SL1 4ST Slough Technology Centre Berkshire | 176526820001 | |||||||
| TEMPLES (NOMINEES) LIMITED | Secretario corporativo | Kemp House 152-160 City Road EC1V 2NX London | 38664760001 | |||||||
| BANNER, Paul Lancelot | Director | Cherry Trees 43 Meadway KT10 9HG Esher Surrey | England | British | 142808820001 | |||||
| BARNES, Eric John | Director | Lodge Farm Cottage Maidensgrove RG9 6EZ Henley On Thames Oxfordshire | British | 29373010004 | ||||||
| BERTRAM, Peter Michael | Director | Royston Road Harston CB22 7GG Cambridge Harston Mill England | England | British | 52852920002 | |||||
| BLOMLEY, Martin James | Director | Cody Technology Park Old Ively Road GU14 0LX Farnborough A2/1064 Hampshire England | England | British | 77672390001 | |||||
| CARTER, Jonathan Philip | Director | 683-685 Stirling Road SL1 4ST Slough Technology Centre Berkshire | England | British | 130117960001 | |||||
| CARTMELL, Philip | Director | Hazeley Lea Hartley Wintney RG27 8ND Hook Tyme Cottage Hampshire | England | British | 74603470010 | |||||
| COURTNEY, Rohan Richard | Director | 683-685 Stirling Road SL1 4ST Slough Technology Centre Berkshire | England | British | 9512790008 | |||||
| CRAWFORD, Mark Stephen | Director | Cody Technology Park Old Ively Road GU14 0LX Farnborough A2/1064 Hampshire England | England | British | 256891910001 | |||||
| CROMM, Gerd Wilhelm | Director | Untermarkstrasse 59a 44267 Dortmund Germany | German | 45682010001 | ||||||
| DAVENHILL, Michael Frederick | Director | Flat 31 79 Gloucester Street SW1V 4EA London | United Kingdom | British | 33959920001 | |||||
| GOZDAWA, Richard Julius | Director | 14 Devonway UB10 0JS Hillingdon Middlesex | England | British | 41159700001 | |||||
| GRANT, John Albert Martin | Director | The Malthouse Manor Lane Claverdon CV35 8NH Warwick Warwickshire | England | British | 55161940001 | |||||
| GUNN, John Humphrey | Director | 23 Edwardes Square W8 6HE London | England | British | 705110002 | |||||
| HENDERSON, Julia Ann | Director | 683-685 Stirling Road SL1 4ST Slough Technology Centre Berkshire | England | British | 39786210001 | |||||
| HEWLETT, Anthony Michael | Director | Camperdown Sycamore Road HP6 6BB Amersham Buckinghamshire | England | British | 97414960001 | |||||
| HOLLAND, Philip John | Director | Station Road BA9 9FE Wincanton Cale House England | England | British | 163838050001 | |||||
| IVINGS, Thomas Edwin | Director | 58 Manor Road OX20 1XJ Woodstock Oxfordshire | Uk | British | 59703880002 | |||||
| KING, Richard | Director | Cody Technology Park Old Ively Road GU14 0LX Farnborough A2/1064 Hampshire England | Uk | British | 167256620001 | |||||
| KINGS, Simon John Nicholson | Director | Cody Technology Park Old Ively Road GU14 0LX Farnborough A2/1064 Hampshire England | England | British | 197059500001 | |||||
| LINDSAY, David | Director | Northwick Terrace NW8 8HU London 47 Clifton Court England | England | British | 205682300001 | |||||
| MCCREE, Andrew Charles | Director | Cody Technology Park Old Ively Road GU14 0LX Farnborough A2/1064 Hampshire England | Scotland | British | 191442730001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TP GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Science Group Plc | 17 feb 2023 | Royston Road Harston CB22 7GG Cambridge Harston Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para TP GROUP LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 23 ene 2017 | 16 feb 2023 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0