TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03152729 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Dirección de la sede social | Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MILLER HOMES (SOUTHERN) LIMITED | 30 ene 1996 | 30 ene 1996 |
| MILLER HOMES (MIDLANDS) LIMITED | 25 ene 1996 | 25 ene 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Gareth Russell Jacob como director el 24 mar 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2025 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Daniel Stewart Wilson como secretario el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 25 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU United Kingdom a Tungsten Building, Central Boulevard Blythe Valley Business Park Solihull B90 8AU el 14 jul 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Arthur Ben Brenton como director el 15 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Ian John Mitchell como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Trevor David Thomas como director el 31 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Gareth Russell Jacob como director el 13 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 jun 2023 au 31 mar 2023 | 1 páginas | AA01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Daniel Stewart Wilson como secretario el 31 may 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Modification des détails de Twigden Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 ago 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de One St Peter's Square Manchester United Kingdom M2 3DE United Kingdom a Tungsten Building Blythe Valley Business Park Solihull West Midlands B90 8AU el 16 ago 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 6 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Gary Bosley Phillips como director el 15 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 dic 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 81 Fountain Street Manchester M2 2EE England a One St Peter's Square Manchester United Kingdom M2 3DE el 05 ago 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Twigden Homes Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 ago 2021 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cese del nombramiento de Philip Higgins como secretario el 28 may 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
¿Quiénes son los directivos de TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENTON, Arthur Ben | Director | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | England | British | 306343990001 | |||||
| ARMITAGE, Matthew | Secretario | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | 193477020001 | |||||||
| DONALDSON, Euan James | Secretario | Woodburn Garvald EH41 4LN Haddington East Lothian | British | 41273760001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Secretario | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GREGORY, Mark Charles | Secretario | 1 Oaken Pin Close MK43 0DZ Cranfield Bedfordshire | British | 83675620002 | ||||||
| GREGORY, Robert William | Secretario | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | British | 109817750001 | ||||||
| HAMILTON, Deborah Pamela | Secretario | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | British | 116752570004 | ||||||
| HIGGINS, Philip | Secretario | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | 262494640001 | |||||||
| MCCOLL, Mary Jean | Secretario | Keysoe Lodge Keysoe Row West MK44 2JF Keysoe Bedfordshire | British | 34757030001 | ||||||
| MELGES, Bethan | Secretario | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | 199705330001 | |||||||
| WALSH, Alistair Bruce | Secretario | 2 Copel Close Highfields Caldecote CB3 7ZQ Cambridge Cambridgeshire | British | 73803050001 | ||||||
| WILSON, Daniel Stewart | Secretario | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building, Central Boulevard England | 299160110001 | |||||||
| ANDERSON, John Bruce | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 29878320002 | |||||
| BAKER, Graham David | Director | The Old Stables Warren Farm Barns Warren Lane MK45 4AS Clophill Bedforshire | British | 48564410002 | ||||||
| BARKE, Timothy John, Mr. | Director | The Paddock Chapel End PE28 5TJ Sawtry Cambridgeshire | England | British | 295385930001 | |||||
| BRAND, Duncan Valentine | Director | Westmill House SG12 0ET Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 16800690001 | |||||
| BROOMFIELD, Matthew | Director | 11 Centenary Road Brampton PE28 4YQ Huntingdon Cambridgeshire | British | 108705890001 | ||||||
| BROWNE, Daniel Harry Rate | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 154494390001 | |||||
| COOPER, Sarah Jayne | Director | M2 2EE Manchester 81 Fountain Street England | United Kingdom | British | 188395230001 | |||||
| CREMIN, Theresa Bernadette | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 185269400001 | |||||
| DIXON, Kevin | Director | 40 Fieldfare Way SG8 7XR Royston Hertfordshire | England | British | 41560840002 | |||||
| DIXON, Kevin | Director | 14 Mallow Walk Studlands Rise SG8 9NF Royston Hertfordshire | British | 41560840001 | ||||||
| GARNER, Laurence | Director | The Cotmanor Gate Sawpit Lane PE28 5QS Hamerton Huntingdon | British | 85157930002 | ||||||
| GORDON-STEWART, Alastair James | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 124512200002 | |||||
| GREGORY, Robert William | Director | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| GREGORY, Robert William | Director | 5 Park Road PE27 5JR St Ives Cambridgeshire | England | British | 109817750001 | |||||
| HODGETTS, John Graham | Director | 15 St Georges Close Brampton PE28 4US Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 111290960001 | |||||
| HOLDOM, Denise Ivy | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Lysander House Bedfordshire United Kingdom | England | British | 116935560002 | |||||
| HOMER, David | Director | 28 Eastwood Drive Highwoods CO4 4EB Colchester Essex | British | 16658920001 | ||||||
| JACOB, Gareth Russell | Director | Central Boulevard Shirley B90 8AU Solihull Tungsten Building England | United Kingdom | British | 303523150001 | |||||
| KING, Christopher | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 81798580013 | |||||
| LAWSON, Ian Michael | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | England | British | 119365330001 | |||||
| MILLER, Keith Manson | Director | Cherry Hollows 1(B)Easter Belmont Road EH12 6EX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 546650002 | |||||
| MITCHELL, Ian John | Director | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | England | British | 69476660001 | |||||
| MOORE, Nicholas Charles | Director | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire | United Kingdom | British | 277811200001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TWIGDEN HOMES SOUTHERN LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twigden Homes Limited | 06 abr 2016 | Blythe Valley Business Park B90 8AU Solihull Tungsten Building West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0