SABA INFRA CARDIFF LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SABA INFRA CARDIFF LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03154700 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
- Otras actividades de apoyo al transporte (52290) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Dirección de la sede social | Mazars Llp Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INDIGO INFRA CARDIFF LIMITED | 05 nov 2015 | 05 nov 2015 |
| VINCI PARK CARDIFF LIMITED | 04 ene 2002 | 04 ene 2002 |
| IMPREGILO PARKING (UK) LIMITED | 05 jul 1996 | 05 jul 1996 |
| IMPREGILO PARKING (UHW) LIMITED | 12 abr 1996 | 12 abr 1996 |
| IMPREGILO PARKING (HEATH) LIMITED | 28 mar 1996 | 28 mar 1996 |
| RJT 210 LIMITED | 02 feb 1996 | 02 feb 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Michelmores Secretaries Limited Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR a Mazars Llp Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD el 29 jul 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR United Kingdom a Michelmores Secretaries Limited Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Indigo Infra Holdings Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 dic 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Josep Oriol Carreras como director el 17 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Wilfried Didier Charles Thierry como director el 11 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Indigo Infra Holdings Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 abr 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de , Oak House Reeds Crescent, Watford, Herts, WD24 4QP a Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR el 26 abr 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed vinci park cardiff LIMITED\certificate issued on 05/11/15 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Michelmores Secretaries Limited como secretario el 12 oct 2015 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKARD, Gary Charles | Secretario | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | 162320950001 | |||||||||||
| MICHELMORES SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House England |
| 107218000001 | ||||||||||
| HERRING, Phillip David | Director | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | United Kingdom | British | 141247820001 | |||||||||
| ORIOL CARRERAS, Josep | Director | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | Spain | Spanish | 253556690001 | |||||||||
| PICKARD, Gary Charles | Director | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1DD London Mazars Llp | United Kingdom | British | 116438300001 | |||||||||
| BARBER, Alistair Michael | Secretario | 13 Foley Road East Streetly Sutton Coldfield B74 3HN Birmingham West Midlands | British | 107070900001 | ||||||||||
| HANKEY, Nicholas | Secretario | Beech Grove HP23 5NU Tring 5 Hertfordshire United Kingdom | British | 128650630001 | ||||||||||
| LOCATELLI, Luigi | Secretario | Flat 1 Lisvane House 66 Mill Road Lisvane CF14 0XN Cardiff South Glamorgan | Italian | 71235150001 | ||||||||||
| TAYLOR, Timothy Robert | Secretario | 56 Grasholm Way Belvedere Place SL3 8WF Langley Berkshire | British | 52404590003 | ||||||||||
| TRISOLINI, Paolo Longobardi | Secretario | 15 Heol Y Bryn Rhiwbina CF4 6HX Cardiff South Glamorgan | Italian | 26794080004 | ||||||||||
| CRESCENT HILL LIMITED | Secretario designado corporativo | Dumfries House Dumfries Place CF10 3FN Cardiff South Glamorgan | 900004610001 | |||||||||||
| BAGNATI, Pietro | Director | 15 Bearfort Court Admirals Landing CF1 5AH Cardiff | Italian | 40476800001 | ||||||||||
| BOUTELIER, Alexandra Florence | Director | Reeds Crescent WD24 4QP Watford Oak House Herts United Kingdom | France | French | 156564810001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Martin | Director | 243 Burnt Ash Hill Grove Park SE12 0QB London | England | British | 11217230001 | |||||||||
| COMORETTO, Giuseppe | Director | Via Gnudi 33 Castiglione Delle Stiniere (Mn)46043 Italy | Italian | 80583690001 | ||||||||||
| CORTI, Riccardo | Director | Viale Italia 1 Sesto San Giovanni FOREIGN Milan Italy | Italian | 56392580002 | ||||||||||
| EVANS, Mark Robert | Director | Painswick Road GL50 2ER Cheltenham 40 Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 70616050011 | |||||||||
| HANKEY, Nicholas | Director | Beech Grove HP23 5NU Tring 5 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 128650630001 | |||||||||
| KALIS, Maximilian | Director | Reeds Crescent WD24 4QP Watford Oak House Herts United Kingdom | Germany | German | 151018260001 | |||||||||
| LOCATELLI, Luigi | Director | Flat 1 Lisvane House 66 Mill Road Lisvane CF14 0XN Cardiff South Glamorgan | Italian | 71235150001 | ||||||||||
| MARTIN, Anthony Cedric Guy | Director | 12 Avenue Du Pavillon Sully 78230 Le Pecq France | French | 78144090002 | ||||||||||
| MORELLO MOSTO, Cesare Arturo | Director | 7 Clive Crescent CF64 1AT Penarth Vale Of Glamorgan | Italian | 69559250001 | ||||||||||
| POUSSIN, Claude | Director | 174 Rue De Courcelles FOREIGN 75017 Paris France | French | 56111040001 | ||||||||||
| PRINCET, Philippe Pierre Edouard | Director | 13 Avenue Robert Andre Vivien 94160 Saint Mande France | France | French | 70956330002 | |||||||||
| TAYLOR, Susan Jane | Director | Oswald London Road SL5 9RY Sunningdale Berks | Great Britain | British | 114425830001 | |||||||||
| TAYLOR, Timothy Robert | Director | 56 Grasholm Way Belvedere Place SL3 8WF Langley Berkshire | British | 52404590003 | ||||||||||
| THIERRY, Wilfried Didier Charles | Director | Avenue Jules Quentin 92000 Nanterre 61 France | France | French | 169088870001 | |||||||||
| THIERRY, Wilfried Didier Charles | Director | 35 Rue Grande Puiselet 77140 Saint Pierre Les Nemours Paris France | France | French | 169088870001 | |||||||||
| ST ANDREWS COMPANY SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Dumfries House Dumfries Place CF10 3FN Cardiff South Glamorgan | 900004600001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SABA INFRA CARDIFF LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saba Infra Holdings Uk Limited | 06 abr 2016 | Reeds Crescent WD24 4PH Watford Oak House Herts England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene SABA INFRA CARDIFF LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 07 jul 2014 Entregado el 15 jul 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 09 oct 2003 Entregado el 15 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First legal mortgage l/h premises comprising two purpose built carparks at the university hospital of wales with all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery, benefit of any covenants, insurances in relation to english mortgaged property, assigns all its right in respect of each relevant contract fixed charge the benefit of any authorisation held in connection with its use of any security asset. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 19 dic 1996 Entregado el 09 ene 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (as borrower) to the chagee under the terms of the facility agreement dated 6TH september 1996 and this charge | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene SABA INFRA CARDIFF LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0