PSP DIGITAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PSP DIGITAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03156669 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PSP DIGITAL LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra PSP DIGITAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | . Turnpike Road RG14 2NX Newbury Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PSP DIGITAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FORUM 147 LIMITED | 08 feb 1996 | 08 feb 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PSP DIGITAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PSP DIGITAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul John Horton como director el 24 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Anne Malyszko como director el 17 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Richard Tiszali como director el 17 abr 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr William Richard Tiszali como director el 08 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Brian Edward Anderson como director el 08 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alec Thomas Lappe como director el 08 feb 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 031566690004 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 031566690003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Registro de la carga 031566690004, creada el 26 ago 2016 | 50 páginas | MR01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul John Horton como director el 29 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jacqueline Mary Marsh como director el 02 mar 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 feb 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Guy Frederick St John Eaton como director el 18 may 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Jacqueline Mary Marsh como director el 18 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Banks como director el 18 may 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PSP DIGITAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON, Brian Edward | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 243492750001 | |||||
| BANKS, Timothy | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United Kingdom | British | 177269610001 | |||||
| LAPPE, Alec Thomas | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 243493380001 | |||||
| MALYSZKO, Anne La Belle | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 245454670001 | |||||
| EELES, Eric John, Doctor | Secretario | 23 Mutton Oaks Binfield RG12 8LZ Bracknell Berkshire | British | 19130790002 | ||||||
| HIGGINS, Steven Jeremy | Secretario | 17 Queens Road RG14 7NH Newbury Berkshire | British | 46764870001 | ||||||
| PROUDLOCK, Nicola Marie | Secretario | Garden Cottage West Meon GU32 1JL Petersfield Hampshire | British | 88234480003 | ||||||
| SPROXTON, Peter James | Secretario | 14 The Moors RG8 7LP Pangbourne Berkshire | British | 100088330001 | ||||||
| FORUM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 42 Cricklade Street SN1 3HD Swindon Wiltshire | 900005660001 | |||||||
| COOPER, Ian Graham | Director | Bunces Lane RG8 7RH Collins End Westholme Barn United Kingdom | United Kingdom | British | 186068780001 | |||||
| CROSS, Howard John | Director | Old Postings North Street GU31 5HG Rogate West Sussex | British | 78376040003 | ||||||
| CROSS, Ray John | Director | Wormsley HR4 8LU Hereford Deerhaven United Kingdom | United Kingdom | British | 186071160001 | |||||
| DERRY, Simon John | Director | Trevona Ashtead Woods Road KT21 2EX Ashtead Surrey | England | British | 89703280001 | |||||
| EATON, Guy Frederick St John | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | England | British | 150889170002 | |||||
| EELES, Eric John, Doctor | Director | 23 Mutton Oaks Binfield RG12 8LZ Bracknell Berkshire | British | 19130790002 | ||||||
| FREDERICKS, Peter George | Director | Danehill Lower Earley RG6 4PB Reading Hartman House Berkshire England | England | British | 95853260003 | |||||
| HIGGINS, Steven Jeremy | Director | 17 Queens Road RG14 7NH Newbury Berkshire | British | 46764870001 | ||||||
| HORTON, Paul John | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United Kingdom | British | 169898500001 | |||||
| MARSH, Jacqueline Mary | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | England | British | 198956590001 | |||||
| MULLIGAN, Martin | Director | Wadham Close Southrop GL7 3NR Lechlade 3 United Kingdom | England | British | 66989250001 | |||||
| PHILLIPS, Timothy John | Director | 47 St Cross Road SO23 9PS Winchester Hampshire | British | 52480350002 | ||||||
| PITMAN, Graham Michael | Director | Chiltern Cottage Christmas Common OX49 5HL Watlington Oxon | England | British | 13368750002 | |||||
| SMITH, Peter | Director | 248 Benham Hill RG18 3AH Thatcham Berkshire | England | British | 89703240001 | |||||
| SMITH, Peter | Director | 1 Abbey Wells Trade Street RG20 9UW Walton Hill Hampshire | British | 46764790002 | ||||||
| SPROXTON, Peter James | Director | 14 The Moors RG8 7LP Pangbourne Berkshire | England | British | 100088330001 | |||||
| TISZALI, William Richard | Director | Turnpike Road RG14 2NX Newbury . Berkshire | United States | American | 243492790001 | |||||
| FORUM DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 42 Cricklade Street SN1 3HD Swindon Wiltshire | 900005650001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PSP DIGITAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snell Advanced Media Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road RG14 2NX Newbury 31 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PSP DIGITAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 26 ago 2016 Entregado el 05 sept 2016 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 11 mar 2014 Entregado el 27 mar 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK262688. Land on the north west side of cutbush close, lower earley, reading t/no BK222477. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 26 feb 2009 Entregado el 06 mar 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each borrower and each other obligor (including the chargor) to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 22 ene 1998 Entregado el 28 ene 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0