EMI GROUP HOLDINGS (UK)

EMI GROUP HOLDINGS (UK)

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEMI GROUP HOLDINGS (UK)
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 03158108
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EMI GROUP HOLDINGS (UK)?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra EMI GROUP HOLDINGS (UK)?

    Dirección de la sede social
    364-366 Kensington High Street
    W14 8NS London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EMI GROUP HOLDINGS (UK)?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MAWLAW 294 LIMITED13 feb 199613 feb 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EMI GROUP HOLDINGS (UK)?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EMI GROUP HOLDINGS (UK)?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Amount capital reduced be credited to reserves 15/11/2016
    RES13

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    L5K1S0SZ

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2015

    19 páginasAA
    L5HW4P5K

    legacy

    105 páginasPARENT_ACC
    L5HW4P68

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2
    L5HW4P60

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2
    L5HW4P5S

    Cese del nombramiento de Boyd Johnston Muir como director el 31 ago 2016

    1 páginasTM01
    X5EN0I7M

    Déclaration annuelle établie au 13 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 feb 2016

    Estado de capital el 17 feb 2016

    • Capital: GBP 1,767,728,176.14
    SH01
    X50YLU29

    legacy

    2 páginasSH20
    L4LWHO4B

    Estado de capital el 09 dic 2015

    • Capital: GBP 1,767,728,176
    5 páginasSH19
    L4LWHO43

    legacy

    2 páginasCAP-SS
    L4LWHO4J

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of capital reserve account 08/12/2015
    RES13

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA
    A4GY4Y8B

    legacy

    135 páginasPARENT_ACC
    A4GY4Y8J

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2
    R4GZSUZK

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2
    A4GY4Y8R

    Déclaration annuelle établie au 13 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 feb 2015

    Estado de capital el 13 feb 2015

    • Capital: GBP 1,767,728,176.14
    SH01
    X416JP9N

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2013

    14 páginasAA
    A3DMEXCO

    legacy

    140 páginasPARENT_ACC
    A3DMEXFC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2
    A3DMEXC0

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2
    A3DMEXCG

    Déclaration annuelle établie au 13 feb 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 feb 2014

    Estado de capital el 14 feb 2014

    • Capital: GBP 1,767,728,176.14
    SH01
    X31PTEW2

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2014 au 31 dic 2013

    1 páginasAA01
    X2Z4IHQV

    ¿Quiénes son los directivos de EMI GROUP HOLDINGS (UK)?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ABIOYE, Abolanle
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Secretario
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    174414710001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Director
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritishInternational Chief Financial Officer163199590001
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Director
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Counsel43836310003
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secretario
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    BritishChartered Secretary96139050001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secretario corporativo
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secretario corporativo
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06902863
    140723560001
    ALEXANDER, Stephen Harold
    39 Wandle Road
    SW17 7DL London
    Director
    39 Wandle Road
    SW17 7DL London
    United KingdomBritishCompany Director126427510001
    ANCLIFF, Christopher John
    13 Camley Park Drive
    SL6 6QF Maidenhead
    Berkshire
    Director
    13 Camley Park Drive
    SL6 6QF Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishSolicitor52876050002
    BACK, Philippa Lucy Foster
    73 Greencoat Place
    Westminster
    SW1P 1DS London
    Director
    73 Greencoat Place
    Westminster
    SW1P 1DS London
    EnglandBritishGroup Treasurer49788930001
    BRATCHELL, Duncan John Timothy
    16 Green End Road
    Boxmoor
    HP1 1QW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    16 Green End Road
    Boxmoor
    HP1 1QW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant35964040002
    BROUWER, Adriaan
    Van Goghlaan 4
    Sassenheim
    2172 Db
    Netherlands
    Director
    Van Goghlaan 4
    Sassenheim
    2172 Db
    Netherlands
    DutchDirector72555660001
    CHADD, Andrew Peter
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    Director
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United KingdomBritishDirector133578890002
    CHRISTIAN, Christopher Lindsay
    47 Court Way
    TW2 7SA Twickenham
    Middlesex
    Director
    47 Court Way
    TW2 7SA Twickenham
    Middlesex
    BritishChartered Secretary15441800002
    CHRISTIAN, Christopher Lindsay
    16 Devoncroft Gardens
    TW1 3PB Twickenham
    Middlesex
    Director
    16 Devoncroft Gardens
    TW1 3PB Twickenham
    Middlesex
    BritishChartered Secretary15441800001
    COTTIS, Stephen Martin
    61 Oaken Grove
    SL6 6HN Maidenhead
    Berkshire
    Director
    61 Oaken Grove
    SL6 6HN Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishChartered Management Accountan36088340002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    BritishChartered Secretary96139050001
    FADIL, Susan Carol
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    Director designado
    Shemer Ash Road
    Hawley
    DA2 7SB Dartford
    Kent
    British900006600001
    FAXON, Roger Conant
    Ninth Avenue
    4th Floor
    NY 10011 New York
    75
    Usa
    Director
    Ninth Avenue
    4th Floor
    NY 10011 New York
    75
    Usa
    UsaAmericanChairman & Ceo Emi Music Publishing161824550001
    GITTER, Geoffrey
    19 The Greenway
    Rayners Lane
    HA5 5DR Pinner
    Middlesex
    Director
    19 The Greenway
    Rayners Lane
    HA5 5DR Pinner
    Middlesex
    BritishDeputy Secretary13725530001
    GUMMERS, Eric Michael
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    Director designado
    9 Vincent Square Mansions
    Walcott Street
    SW1P 2NT London
    British900006590001
    KENNEDY, Christopher John
    31 Bath Road
    Chiswick
    W4 1LJ London
    Director
    31 Bath Road
    Chiswick
    W4 1LJ London
    United KingdomBritishFinance Director62227310005
    MACASKILL, Ian Roderick
    25 Merrivale Gardens
    Goldsworth Park
    GU21 3LX Woking
    Surrey
    Director
    25 Merrivale Gardens
    Goldsworth Park
    GU21 3LX Woking
    Surrey
    BritishUk Treasurer69939110001
    MUIR, Boyd Johnston
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Director
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United StatesBritishEvp & Cfo172824510001
    NAUGHTON, Shane Paul
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    Director
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    EnglandIrishChartered Accountant150186560001
    PRIOR, Ruth Catherine
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    Director
    Wrights Lane
    W8 5SW London
    27
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant161825160001
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Director
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritishCompany Director58870910002
    ROLING, Christopher John
    82 Oak End Way
    SL9 8DB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    82 Oak End Way
    SL9 8DB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British AmericanManaging Director119379800001

    ¿Tiene EMI GROUP HOLDINGS (UK) alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A recorded music division security agreement
    Creado el 01 oct 2008
    Entregado el 10 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors and the participating employers on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its copyrights which are governed by english law, all of its music contracts and exploitation contracts, and all receivables relating to any copyright asset. Floating charge all of its assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A. London Branch (The Security Agent)
    Transacciones
    • 10 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 dic 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 29 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of accession and charge
    Creado el 28 ene 2008
    Entregado el 31 ene 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors and the participating employers under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank, N.A., London Branch (The Security Agent)
    Transacciones
    • 31 ene 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 dic 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 29 oct 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0