M.T.K. CONTAINERS LIMITED

M.T.K. CONTAINERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaM.T.K. CONTAINERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03167857
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    • (2821) /

    ¿Dónde se encuentra M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Rsm Robson Rhodes
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INFOMINI LIMITED05 mar 199605 mar 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal

    2 páginas3.6

    legacy

    1 páginas405(2)

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal

    3 páginas3.6

    legacy

    1 páginas288b

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal

    3 páginas3.6

    legacy

    1 páginas288b

    Estado de situación patrimonial en la administración concursal tras el informe a los acreedores

    16 páginas3.3

    Estado de situación patrimonial en la administración concursal tras el informe a los acreedores

    10 páginas3.3

    Informe del receptor administrativo

    12 páginas3.10

    Certificado de constitución modificado del comité de acreedores

    1 páginas3.4

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas405(1)

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    páginas363(353)

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    10 páginas395

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de M.T.K. CONTAINERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BELL, Ian David
    83a Gilesgate
    DH1 1HY Durham
    County Durham
    Director
    83a Gilesgate
    DH1 1HY Durham
    County Durham
    British70976410001
    WITTLIN, Felix Max, Doctor
    2 Chemin Biguex
    Chailly-Montreux
    Ch 1816
    Switzerland
    Director
    2 Chemin Biguex
    Chailly-Montreux
    Ch 1816
    Switzerland
    Swiss72634360001
    AITKEN, David Andrew
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    British87190800001
    COLLINS, Michael David Gibson
    15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Buckinghamshire
    Secretario
    15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Buckinghamshire
    British60886260003
    COLLINS, Michael David Gibson
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60886260002
    DEAN, Stephen Donald Charles
    49 Cromford Road
    SW18 1PA London
    Secretario
    49 Cromford Road
    SW18 1PA London
    British67535290002
    NOAH, Frank Edward
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Secretario
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British27829510002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AITKEN, David Andrew
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    Director
    32 Kent Court
    Kingston Park
    NE3 2XH Newcastle Upon Tyne
    British87190800001
    BROMLEY-MARTIN, Robin Hampden
    Leisure Cottage
    Church Road
    GU29 0EH West Lavington
    Director
    Leisure Cottage
    Church Road
    GU29 0EH West Lavington
    United KingdomBritish110319440001
    COLLINS, Michael David Gibson
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Stockwell House 15 High Street
    Haddenham
    HP17 8ES Aylesbury
    Buckinghamshire
    British60886260002
    DAVIDSON, Alan
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    80 Haddington Road
    NE25 9UY Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritish30827780001
    DAVIES, Andrew Owen Evan
    The Lawn Brent Hill
    ME13 7EF Faversham
    Kent
    Director
    The Lawn Brent Hill
    ME13 7EF Faversham
    Kent
    British40795600002
    DEAKIN, Graham Ronald
    69 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    69 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British60807750001
    FISKE, Barry John
    8 Staitheway Road
    NR12 8TH Wroxham
    Norfolk
    Director
    8 Staitheway Road
    NR12 8TH Wroxham
    Norfolk
    United KingdomBritish126228790001
    KUTLUOGLU, Mehmet Tayfun
    14 Parc Chateau Banquet
    1202 Geneva
    Switzerland
    Director
    14 Parc Chateau Banquet
    1202 Geneva
    Switzerland
    Turkish51924640001
    KUTLUOGLU, Omer
    7 Broad Garth
    Blue Anchor Court
    NE1 3HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    7 Broad Garth
    Blue Anchor Court
    NE1 3HE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British75656880001
    MORRIS, John
    Le Clos De La Brague
    Qtr Tamarins
    06410 Biot
    France
    Director
    Le Clos De La Brague
    Qtr Tamarins
    06410 Biot
    France
    British52203280001
    NOAH, Frank Edward
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Director
    Old Mill Farm
    Back Lane, Oddington
    GL56 0XL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    British27829510002
    TASKENT, Turul
    57 Granville Court
    NE2 1TR Newcastle Upon Tyne
    North East
    Director
    57 Granville Court
    NE2 1TR Newcastle Upon Tyne
    North East
    Turkish75656750001
    THOMAS, John Alan, Sir
    Highwood Park Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    Director
    Highwood Park Nan Clarks Lane
    NW7 4HH London
    United KingdomBritish10699990001
    WILKINSON, John
    7 Oakfield Close
    SR3 3RT Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    7 Oakfield Close
    SR3 3RT Sunderland
    Tyne & Wear
    British60807830001
    WINGFIELD, Andrew
    101 Broom Lane
    Whickham
    NE16 4PT Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Director
    101 Broom Lane
    Whickham
    NE16 4PT Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish52203320001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene M.T.K. CONTAINERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Chattel mortgage
    Creado el 17 jul 2001
    Entregado el 21 jul 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Various chattels as specified in schedule to form 395 relative to the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jul 2001Registro de un cargo (395)
    Floating charge over all stock
    Creado el 27 jun 2000
    Entregado el 06 jul 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement
    Breve descripción
    All stock owned by the borrower including raw materials and components and work in progress partly finished and finished goods for specific stock tanks.
    Personas con derecho
    • North East Regional Investment Fund Limited
    Transacciones
    • 06 jul 2000Registro de un cargo (395)
    Chattels mortgage
    Creado el 30 jun 1998
    Entregado el 30 jun 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    One tursdale engineering access platform ref no 1084..one rocom tsc imagination telephone system ref no 970387..xbs computer equipment ref no 1216..for further details see schedule to form 395.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Group Limited
    Transacciones
    • 30 jun 1998Registro de un cargo (395)
    Chattels mortgage
    Creado el 27 mar 1998
    Entregado el 30 mar 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to the 395 as one vacublast international waffle floor blastroom ref no 131,383,1022 one anopol hydro station ref 786 one xbs deskpro 2000 pc ref 834. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Group Limited
    Transacciones
    • 30 mar 1998Registro de un cargo (395)
    Chattels mortgage
    Creado el 23 feb 1998
    Entregado el 23 feb 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    One casanova hydraulic guillotine shear model vce-16 serial no.3942 Register no.97-p-001, one casanova hydraulic rolling machine model pcv-22/s serial no.3943 Register no:97-p-002, real time x-ray camera register no.97-p-061 for details of further chattels please see form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Group Limited
    Transacciones
    • 23 feb 1998Registro de un cargo (395)
    Chattels mortgage
    Creado el 07 ene 1998
    Entregado el 08 ene 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Emi x ray cell and manipulators d/n SB373397 3 x dalby commercial vehicle spay booth/ovens s/n SB3733A97 for further details of equipment charged reger to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Forward Trust Group Limited
    Transacciones
    • 08 ene 1998Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 27 ago 1997
    Entregado el 28 ago 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 28 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 14 jun 2002Nombramiento de un receptor o gerente (405 (1))
    • 25 ene 2005Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (405 (2))
      • Número de expediente 1

    ¿Tiene M.T.K. CONTAINERS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 ago 1997Fecha del instrumento
    Administrador judicial nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Charles William Anthony Escott
    Grant Thornton Uk Llp
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds West Yorkshire,
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    St George House
    LS1 3DQ 40 Great George Street
    Leeds West Yorkshire,
    Michael John Hore
    Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London
    Profesional
    Robson Rhodes
    186 City Road
    EC1V 2NU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0