CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD

CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03167993
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD?

    Dirección de la sede social
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRYGONE PROPERTIES LTD16 dic 200516 dic 2005
    SMARTSENSE LIMITED02 abr 199602 abr 1996
    SMARTSCENE LIMITED05 mar 199605 mar 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cambio de datos del director Mr Gary Ryan Fee el 27 ago 2020

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mrs Rosamund Margaret Marshall como director el 16 abr 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr John Guy Casagrande como director el 16 abr 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Gary Ryan Fee como director el 16 abr 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Walter Tugendhat como director el 13 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Dave Lissy como director el 13 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Dreier como director el 13 abr 2020

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 23

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr James Walter Tugendhat como director el 10 nov 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 ene 2016

    Estado de capital el 27 ene 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 03 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 dic 2015

    Estado de capital el 03 dic 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Mary Ann Tocio como director el 01 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 abr 2015

    Estado de capital el 01 abr 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Secretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    170449670001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican70853820001
    CASAGRANDE, John Guy
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican269010340001
    FEE, Gary Ryan
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United KingdomBritish269008830002
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    EnglandBritish269043470001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Secretario
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Secretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    British169843720001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Secretario designado corporativo
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003990001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    BULL, Malcolm Richard
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    Director
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    EnglandBritish10155680001
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Director
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican170443250001
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Director
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LEWIS, David
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    Director
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    British51773710002
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican218331690001
    MALCOLMSON, John Bryce
    10 Holyoak Crescent
    Horsell
    GU21 4PN Woking
    Surrey
    Director
    10 Holyoak Crescent
    Horsell
    GU21 4PN Woking
    Surrey
    British51773690001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    TICE, Richard James Sunley
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Director
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish151240670006
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    UsaUsa177507090001
    TUGENDHAT, James Walter
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United KingdomBritish218306870001
    WHITLAM, Paul
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    Director
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    British47737380001
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Director designado corporativo
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bright Horizons Family Solutions Limited
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    27 ene 2017
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una firma que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa firma (en su calidad como tales) tienen el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental debenture
    Creado el 12 may 2011
    Entregado el 20 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All it's right title interest and benefit in and to the land see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creado el 14 nov 2008
    Entregado el 18 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All it's right title interest and benefit in and to the land see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 18 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 09 may 2008
    Entregado el 20 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £36,000=00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The cash sum of £36,000.
    Personas con derecho
    • Classic Management Services Limited
    Transacciones
    • 20 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 16 dic 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 09 may 2008
    Entregado el 16 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H former garage premises grena road richmond surrey t/n TGL189133 and the security assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 16 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creado el 03 abr 2008
    Entregado el 10 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H inglewood farm sonning lane sonning t/no BK225651,f/h land adjoining inglewood house sonning lane sonning berkshire t/no BK309428 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 10 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental debenture being supplemental to a debentured given on 21 december 2004 and
    Creado el 11 feb 2008
    Entregado el 13 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Strathmore house brighton road banstead t/n SY381533, high trees wokingham road rounds hill bracknell t/n BK159196, 1 cob close tassel road bury st edmunds t/n's SK251153 and SK284737, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 13 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creado el 04 dic 2007
    Entregado el 19 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property at academy day nursery gibson drive kings hill west malling (t/no K824499) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creado el 22 oct 2007
    Entregado el 26 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property owned by the mortgagor k/a merrow clinic 19 boxgrove lane merrow guildford t/no SY259691. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transacciones
    • 26 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creado el 30 jun 2006
    Entregado el 05 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property at stepping stones 105 penn hill avenue poole dorset t/no DT47303 and f/h property k/a moonacre potterne way verwood dorset t/no DT67285. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 05 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creado el 31 ene 2006
    Entregado el 08 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H shortlands united reform church 84-90 martins road bromley t/no SGL584373, f/h 48 sydenham road croydon t/no SGL615676 and f/h 83A belmont hill lewisham london t/no SGL193573.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 08 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Security accession deed
    Creado el 06 jun 2005
    Entregado el 16 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    1) f/h property k/a the green, frimley green, surrey GU16 6HF, t/n SY105671, 2) f/h property k/a rushmoor independent school, 40 reading road, farnborough, t/n HP559226, 3) f/h property k/a hatton hill nursery, hatton hill, windlesham, surrey, t/n SY420855 and SY565088, see form 395 for other properties charged; and any interest in any other land, all shares and all related distribution rights;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transacciones
    • 16 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Accession deed to intercreditor deed
    Creado el 06 jun 2005
    Entregado el 16 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The company agrees to become a party to and be bound by the intercreditor deed as an obligor, will upon demand by the security trustee pay an amount equal to the amount of all payments or distributions of or in respect of any junior liablities in cash or in kind;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transacciones
    • 16 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 05 ago 2003
    Entregado el 09 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property known as nursery school site, rail road heath, fleet, hert, hampshire t/n HP613289. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that freehold property known as farnborough day nursery formerly rushmore independent school 40 reading road farnborough rushmore hampshire title number HP559226. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that leasehold property known as land and premises situate at and known as the old toll house and the new toll house sandown park surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that freehold property known as hatton hill day nursery being the land and buildings on the south side of hatton hill windlesham surrey heath surrey title number SY420855 and all that freehold land laying to the south west of hatton hill windlesham surrey heath surrey title number SY565088. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 nov 2002
    Entregado el 17 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All that freehold property known as frimley green day nursery 1 the green frimley green surrey heath surrey GU16 6HF title number SY105671. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 31 ene 2002
    Entregado el 20 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £310,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Freehold property k/a land at elvetham heath fleet hampshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 jul 2000
    Entregado el 12 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £295,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    1 the green frimley green camberley surrey.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 sept 1998
    Entregado el 11 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a rushmoor independent school comprising piece of land having a frontage of 80 feet to the north side of reading road farnborough. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 ene 1998
    Entregado el 07 feb 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property at 22 crawley hill canberley t/no;-SY166415.
    Personas con derecho
    • Sunley Ventures Limited
    Transacciones
    • 07 feb 1998Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 jul 1997
    Entregado el 06 ago 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Mylesdown 22 crawley hill camberley street surrey t/n sy 166415.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 1997Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 14 jun 1996
    Entregado el 24 jun 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the southside of hatton hill windlesham and land lying to the south west ofhatton hill widlesham surrey t/no SY420855 & sy 565088.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 jun 1996Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 abr 1996
    Entregado el 01 may 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 may 1996Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0