INN BUSINESS (MARR) LIMITED

INN BUSINESS (MARR) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINN BUSINESS (MARR) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03171064
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INN BUSINESS (MARR) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra INN BUSINESS (MARR) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INN BUSINESS (MARR) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INN BUSINESS (MARR) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de David Forde como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    2 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    legacy

    79 páginasPARENT_ACC

    Nombramiento de Mr Sean Michael Paterson como director el 24 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David James Tannahill como director el 24 abr 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 24 ago 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 19 ago 2017

    3 páginasAA

    Modification des détails de Punch Taverns (Ib) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2017

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE el 08 sept 2017

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 29 ago 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr David Forde como director el 29 ago 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 29 ago 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 29 ago 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher John Moore como director el 29 ago 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Lawson John Wembridge Mountstevens como director el 29 ago 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David James Tannahill como director el 29 ago 2017

    2 páginasAP01

    Notification de Heineken Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 ago 2017

    2 páginasPSC02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 20 ago 2016

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de INN BUSINESS (MARR) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Director
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628210001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BROWN, Robert Adam Southall
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    Secretario
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    BritishAccountant67809020001
    HARRINGTON, Columb
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Secretario
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    IrishAccountant51845740002
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488340001
    JONES, Ian Andrew
    6 Pages Croft
    HP4 1BX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    6 Pages Croft
    HP4 1BX Berkhamsted
    Hertfordshire
    British54298280003
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161624420001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishSecretary637110001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector180590780001
    JACKSON, Alan Marchant
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    Director
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director18341590001
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Director
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritishDirector79388130005
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Director
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    BritishChartered Accountant43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector237381690001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INN BUSINESS (MARR) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc065527
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 abr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro1899248
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene INN BUSINESS (MARR) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 14 sept 1999
    Entregado el 05 oct 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors each of them to the secured creditors (or any of them) under the facility documents (or any of them) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Chase Manhattan International Limited (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transacciones
    • 05 oct 1999Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and fixed and floating charge
    Creado el 06 mar 1996
    Entregado el 23 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company,united breweries PLC (the parent) and the wiltshire brewery property company limited or any other person to the chargee under or arising in connection with the financing documents (as defined) or any of them
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Yorkshire Bank PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and fixed and floating charge
    Creado el 06 mar 1996
    Entregado el 23 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company,united breweries PLC (the parent) and the wiltshire brewery property company limited (the borrower) or any other person to the chargee under or arising in connection with the financing documents (as defined) or any of them
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The National Mortgage Bank PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and fixed and floating charge
    Creado el 06 mar 1996
    Entregado el 23 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company,united breweries PLC (the parent) and the wiltshire brewery property company limited (the borrower) or any other person to the chargee under or arising in connection with the financing documents (as defined) or any of them
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and fixed and floating charge
    Creado el 06 mar 1996
    Entregado el 23 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company,united breweries PLC (the parent and the wiltshire brewery property company limited (the borrower) or any other person to the chargee under or arising in connection with the financing documents (as defined) or any of them
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Adam & Company PLC
    Transacciones
    • 23 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 24 sept 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Single debenture
    Creado el 06 mar 1996
    Entregado el 21 mar 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 21 mar 1996Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0