DIGI-MEDIA VISION LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | DIGI-MEDIA VISION LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03173930 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DIGI-MEDIA VISION LIMITED?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra DIGI-MEDIA VISION LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Callaghan Square CF10 5BT Cardiff United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DIGI-MEDIA VISION LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NDS LIMITED | 31 jul 1996 | 31 jul 1996 |
| NEWS DATACOM (UK) LIMITED | 26 jul 1996 | 26 jul 1996 |
| ALNERY NO. 1562 LIMITED | 15 mar 1996 | 15 mar 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DIGI-MEDIA VISION LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 27 jul 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DIGI-MEDIA VISION LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Evan Barry Sloves el 27 nov 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 jul 2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 jul 2018 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de One London Road Staines Middlesex TW18 4EX a 1 Callaghan Square Cardiff CF10 5BT el 11 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 31 ago 2018
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Ismat Levin como secretario el 09 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Evan Sloves como director el 28 jun 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ismat Levin como director el 09 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 jul 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jul 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Sajaid Rashid como director el 16 mar 2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David James Sweet como director el 16 mar 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 jul 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DIGI-MEDIA VISION LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASHID, Sajaid | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham 9-11 Middlsex United Kingdom | England | British | 227062400001 | |||||
| SLOVES, Evan Barry | Director | East Tasman Drive 95134 San Jose 300 United States | United States | American | 99784540002 | |||||
| LEVIN, Ismat | Secretario | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | British | 83241580001 | ||||||
| MEDLOCK, Charles Richard Kenneth | Secretario | 1 Blackwater View Lower Sandhurst Road Finchampstead RG40 3TF Wokingham Berkshire | British | 23450040004 | ||||||
| NARDINI, Gregory George | Secretario | Upper Flat 163 York Way N7 9LN London Greater London | Italian | 126345260001 | ||||||
| STEHRENBERGER, Peter Walter | Secretario | The Knapp Oak Way RH2 7ES Reigate Surrey | Swiss | 415350001 | ||||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Secretario | 25 Grove Road LU7 1SF Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 100885620001 | ||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secretario designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| FLYNN, Douglas Ronald | Director | 7 Alleyn Park SE21 8AU London | Australian | 68122700001 | ||||||
| GERSH, Alexander | Director | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | United Kingdom | British | 174100540001 | |||||
| HUTSON, Stephen Frank | Director | 17a Chequers Close PE28 9QY Fenstanton Cambridgeshire | British | 54640360001 | ||||||
| LEVIN, Ismat | Director | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | England | British | 83241580001 | |||||
| LINFORD, Richard Martin | Director | Four Beeches Beech Close KT11 2EN Cobham Surrey | United Kingdom | British | 77209960001 | |||||
| MEDLOCK, Charles Richard Kenneth | Director | 1 Blackwater View Lower Sandhurst Road Finchampstead RG40 3TF Wokingham Berkshire | British | 23450040004 | ||||||
| NARDINI, Gregory George | Director | Upper Flat 163 York Way N7 9LN London Greater London | Italian | 126345260001 | ||||||
| NIELSEN, Gorm Ward | Director | TW18 4EX Staines One London Road Middlesex | United Kingdom | British | 169694340001 | |||||
| PELED, Abraham, Dr | Director | 28 Wynnstay Gardens W8 London | United States | 44312940003 | ||||||
| SWEET, David James | Director | New Square Bedfont Lakes TW14 8HA Feltham 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 161536210001 | |||||
| WINDRAM, Michael David, Dr | Director | 1 Hickory Drive SO22 6NJ Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 64721970002 | |||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Director | London Road TW18 4EX Staines One Middlesex | United Kingdom | British | 100885620001 | |||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Director designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Director designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de DIGI-MEDIA VISION LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nds Finance Limited | 06 abr 2016 | Callaghan Square CF10 5BT Cardiff 1 South Glamorgan United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene DIGI-MEDIA VISION LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 10 mar 2011 Entregado el 18 mar 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the borrowers and the other loan parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 06 feb 2009 Entregado el 09 feb 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 28 ene 2009 Entregado el 30 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0