CLICK TV LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLICK TV LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03179628
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLICK TV LIMITED?

    • Actividades de distribución de programas de televisión (59133) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra CLICK TV LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chiswick Green
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLICK TV LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VIRGIN CENTURY TELEVISION LIMITED30 abr 199630 abr 1996
    YOUNGMASTER LIMITED28 mar 199628 mar 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLICK TV LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLICK TV LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Melissa Sterling como secretario el 23 ene 2017

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Ms Anna Maria Redin como director el 11 mar 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Yong-Nam Mathias Hermansson como director el 11 mar 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Nombramiento de Ms Emma Marie Bjurman como director el 01 jul 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Beeston como director el 06 ago 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jens Kristoffer Eriksson como director el 30 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Melissa Sterling como secretario el 31 ago 2016

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 28 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 abr 2016

    Estado de capital el 25 abr 2016

    • Capital: GBP 1,368
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    3 páginasAA

    Nombramiento de Ms Melissa Sterling como secretario el 01 jul 2015

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Jakob Mejlhede como director el 15 may 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Chris Barton Pye como director el 15 may 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan William Courtis Searle como secretario el 30 jun 2015

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Jonathan William Courtis Searle como director el 30 jun 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 28 mar 2015 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 abr 2015

    Estado de capital el 17 abr 2015

    • Capital: GBP 1,368
    SH01

    Nombramiento de Mr Jens Kristoffer Eriksson como director el 02 jul 2014

    AP01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Bengt Patrick Svensk como director el 02 jul 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 28 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 abr 2014

    Estado de capital el 01 abr 2014

    • Capital: GBP 1,368
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de CLICK TV LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    STERLING, Melissa
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62 - 65
    England
    Secretario
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62 - 65
    England
    223061200001
    BJURMAN, Emma Marie
    Nice Entertainment
    Frihamnsgatan
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    Director
    Nice Entertainment
    Frihamnsgatan
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    SwedenSwedish213718530001
    FOX, Jeremy Simon
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    United Kingdom
    Director
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    United Kingdom
    United KingdomUnited Kingdom101506410001
    MEJLHEDE, Jakob
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    Director
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    EnglandDanish197849300001
    REDIN, Anna Maria
    Skeppsbron 18
    111 30 Stockholm
    Mtg
    Sweden
    Director
    Skeppsbron 18
    111 30 Stockholm
    Mtg
    Sweden
    SwedenSwedish219537210001
    FOX, Jeremy Simon
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    Secretario
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    United Kingdom101506410001
    JACKSON, Jonathan Christopher
    c/o Digital Rights Group
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    England
    Secretario
    c/o Digital Rights Group
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    62-65
    England
    160439300001
    KIRBY, Robert
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Secretario
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    172334410001
    PROTHEROE, Ann
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    Secretario
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    British95090130001
    SEARLE, Jonathan William Courtis
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Secretario
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    181966150001
    STERLING, Melissa
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    65
    England
    Secretario
    Chandos Place
    WC2N 4HG London
    65
    England
    200052450001
    C H REGISTRARS LIMITED
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Secretario corporativo
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    39694450001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BEESTON, Richard
    Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd 610
    United Kingdom
    Director
    Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd 610
    United Kingdom
    United KingdomBritish140875470001
    DEBOER II, Louis
    25 Central Park West
    New York Ny10023
    FOREIGN Usa
    Director
    25 Central Park West
    New York Ny10023
    FOREIGN Usa
    American63892320001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Director
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritish68747470001
    ERIKSSON, Jens Kristoffer
    Frihamnsgatan 28
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    Director
    Frihamnsgatan 28
    11556 Stockholm
    28
    Sweden
    SwedenSwedish189305710001
    FOX, Jeremy Simon
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    Director
    11 Parliament Hill
    NW3 2SY London
    United KingdomUnited Kingdom101506410001
    FOX, Paul Leonard, Sir
    20 The Rose Walk
    WD7 7JS Radlett
    Hertfordshire
    Director
    20 The Rose Walk
    WD7 7JS Radlett
    Hertfordshire
    British7691960001
    HERMANSSON, Yong-Nam Mathias
    Box 2094
    Stockholm
    Modern Times Group Mtg Ab
    103 13
    Sweden
    Director
    Box 2094
    Stockholm
    Modern Times Group Mtg Ab
    103 13
    Sweden
    SwedenSwedish179474460001
    IBBETT, Kenneth Richard Andre
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    Director
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    United KingdomBritish34929900001
    JACKSON, Jonathan Christopher
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Director
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    EnglandBritish77844330002
    JENNINGS, Carolyn Susan
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    Director
    35 Old Queen Street
    SW1H 9JD London
    British7967610001
    KAWASH, Anmar Jeremy
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    Director
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    EnglandBritish154929030001
    MEEK, Kingsley John Neville
    24 Church Vale
    N2 9PA London
    Director
    24 Church Vale
    N2 9PA London
    United KingdomBritish37016140002
    PROTHEROE, Ann
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    Director
    15 University Mansions
    Lower Richmond Road
    SW15 1EP London
    British95090130001
    PYE, Chris Barton
    Brooks Road
    W4 3BJ London
    3 Cope Studios
    Uk
    Director
    Brooks Road
    W4 3BJ London
    3 Cope Studios
    Uk
    United KingdomBritish179791340001
    SEARLE, Jonathan William Courtis
    Chiswick Green
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd
    Uk
    Director
    Chiswick Green
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Viasat Broadcasting Uk Ltd
    Uk
    United KingdomBritish131420990001
    SVENSK, Bengt Patrick
    Magasin 3
    Frihamnsgatan 28
    Stockolm
    Mgt Studios
    115 99
    Sweden
    Director
    Magasin 3
    Frihamnsgatan 28
    Stockolm
    Mgt Studios
    115 99
    Sweden
    SwedenSwedish179488050001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CLICK TV LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    06 abr 2016
    610 Chiswick High Road
    W4 5RU London
    Chiswick Green
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02228654
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene CLICK TV LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 23 nov 2007
    Entregado el 11 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ingenious Media Active Capital Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 11 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 23 nov 2007
    Entregado el 11 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ingenious Media Active Capital Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 11 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 28 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ingenious Media Active Capital Limited
    Transacciones
    • 28 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 11 ene 2007
    Entregado el 01 feb 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ingenious Media Active Capital Limited (The Trustee)
    Transacciones
    • 01 feb 2007Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0