PRESS SELECT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PRESS SELECT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03182407 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PRESS SELECT LIMITED?
- Otras actividades de servicios de información n.c.o.p. (63990) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra PRESS SELECT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Broadgate EC2M 2QS London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PRESS SELECT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRESS SELECT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 28 dic 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Harvey Roberts Richardson como director el 27 ene 2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Low como director el 27 ene 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Keir Murray Fawcus como director el 14 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Roger Haworth como director el 14 jul 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Lacey como secretario el 06 jun 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Roger Haworth como director el 12 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Lacey como director el 06 jun 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Wpp Group (Nominees) Limited como secretario el 12 ene 2015 | 3 páginas | AP04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2014 au 31 dic 2014 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PRESS SELECT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Secretario corporativo | Farm Street W1J 5RJ London 27 England |
| 80143770001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Giles Harvey Roberts | Director | Broadgate EC2M 2QS London 1 | England | British | 224284590001 | |||||||||
| BANNER, Christopher | Secretario | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| BANNER, Christopher | Secretario | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| CROMACK, Andrew Michael | Secretario | 23 Knole Road ME5 8PJ Chatham Kent | British | 78040930001 | ||||||||||
| GRAEME, Dorothy May | Secretario designado | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||||||
| GULLIVER, John Keith | Secretario | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | British | 147777590001 | ||||||||||
| LACEY, Stephen | Secretario | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | 164062390001 | |||||||||||
| LOW, Peter | Secretario | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | 148751160001 | |||||||||||
| LOW, Peter | Secretario | Flat 5 186 St Johns Street EC1V 4JZ London | British | 65476890002 | ||||||||||
| OKORE, Maxwell | Secretario | 219 South Croxted Road SE21 8AY London | British | 23396630001 | ||||||||||
| STANNETT, Robert William | Secretario | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | British | 141063520001 | ||||||||||
| BANNER, Christopher | Director | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| DOLTON, Stephen | Director | 99 Cumnor Hill OX2 9JR Oxford | British | 70990450005 | ||||||||||
| FAWCUS, Keir Murray | Director | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 84594470003 | |||||||||
| GRAEME, Lesley Joyce | Director designado | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||||||
| GULLIVER, John Keith | Director | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | United Kingdom | British | 147777590001 | |||||||||
| HARKNESS, Peter Martin | Director | 19 Horsley Court Montaigne Close Regency Street SW1 4BF London | United Kingdom | British | 146757430001 | |||||||||
| HAWORTH, John Roger | Director | Broadgate EC2M 2QS London 1 | England | British | 91354480002 | |||||||||
| HILLIARD, Charles Stephen | Director | 18 Albion Works Studios 63 Sigdon Road E8 1AW London | British | 104848990001 | ||||||||||
| KNIGHT, Martin | Director | The Cuttings 57 Cheam Road East Ewell KT17 3EB Epsom Surrey | England | British | 13326400003 | |||||||||
| LACEY, Stephen | Director | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 88368490002 | |||||||||
| LOW, Peter | Director | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 65476890002 | |||||||||
| OKORE, Maxwell | Director | 219 South Croxted Road SE21 8AY London | British | 23396630001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Jonathan Paul | Director | 7 Hatton Close Chafford Hundred RM16 6RP Grays Essex | United Kingdom | British | 104848170001 | |||||||||
| STANLEY CLAMP, Richard | Director | The Basement Flat 63 Belsize Avenue NW3 4QN London | British | 47274840001 | ||||||||||
| STANNETT, Robert William | Director | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | England | British | 141063520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PRESS SELECT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precise Media Group Holdings Limited | 06 abr 2016 | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene PRESS SELECT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 01 abr 2005 Entregado el 15 abr 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any chargor or other member of the group to the chargee (the "security trustee") as agent and trustee for itself and each of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 26 jul 2001 Entregado el 14 ago 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 18 feb 1999 Entregado el 25 feb 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción First fixed charge all discounted debts and the other debts and all the companys rights under any supply contract giving rise to a discounted debt or other debt including all goods under any such contract together by way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0