ST. JAMES'S PLACE PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaST. JAMES'S PLACE PLC
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 03183415
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ST. JAMES'S PLACE PLC?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ST. JAMES'S PLACE PLC?

    Dirección de la sede social
    St. James's Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    Gloucestershire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ST. JAMES'S PLACE PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ST. JAMES'S PLACE CAPITAL PLC16 ago 199616 ago 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ST. JAMES'S PLACE PLC?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ST. JAMES'S PLACE PLC?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta13 jun 2026
    Próxima declaración de confirmación vence27 jun 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta13 jun 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ST. JAMES'S PLACE PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 17 dic 2025

    • Capital: GBP 79,065,339
    3 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 08 dic 2025

    • Capital: GBP 79,063,426.5
    3 páginasSH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 nov 2025

    • Capital: GBP 79,061,589
    3 páginasSH01

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 14 oct 2025

    • Capital: GBP 79,055,926.50
    6 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 07 oct 2025

    • Capital: GBP 79,083,226.50
    6 páginasSH06

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    25 nov 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    legacy

    páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    legacy

    4 páginasRP01SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 ago 2025

    • Capital: GBP 79,893,457.65
    4 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    26 nov 2025Replaced A replacement SH01 was registered 26/11/25 as the original contained an error

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    19 nov 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 30 sept 2025

    • Capital: GBP 79,228,126.50
    6 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    07 nov 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate stamp duty has been paid on this transaction.

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 19 ago 2025

    • Capital: GBP 80,040,735.90
    6 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 23 sept 2025

    • Capital: GBP 9,368,436.50
    6 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    03 nov 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 30 oct 2025

    • Capital: GBP 80,187,401.25
    4 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    25 nov 2025Replaced A replacement SH01 was registered on 25/11/2025

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 oct 2025

    • Capital: GBP 80,186,688.75
    4 páginasSH01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    25 nov 2025Replaced A replacement SH01 was registered on 25/11/2025

    ¿Quiénes son los directivos de ST. JAMES'S PLACE PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DALE, Jonathan
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Secretario
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    285453520001
    ANAND, Rooney
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    EnglandBritish330778240001
    BECK, Helen Claire
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish337547470001
    FITZPATRICK, Mark Thomas
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    EnglandIrish314262460001
    FRASER, Simon William David
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish96378620001
    HILARY, Rosemary
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish148315490001
    HITCHINS, John Charles Fortescue
    St. James's Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place Plc
    Glos
    United Kingdom
    Director
    St. James's Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place Plc
    Glos
    United Kingdom
    EnglandBritish289434560001
    JAMES, Penelope Jane
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish337547440001
    MANDUCA, Paul Victor Falzon Sant
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish,Maltese7212170004
    WADDINGTON, Caroline Mary
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish75652080005
    ARMITAGE, Matthew
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    Secretario
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    British98110790002
    FRASER, Kay Lisa
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    Secretario
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    181478470001
    GLADMAN, Hugh John
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    Secretario
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    British41485310006
    KELLY, Elizabeth Janet
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    Secretario
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    199677510001
    LANGFIELD, Andrea Valerie
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    Secretario
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    British52526910001
    MEACHAM, Jayne Michelle
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    Secretario
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James Place House
    Gloucestershire
    British158167450001
    MEACHAM, Jayne Michelle
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    Secretario
    Uk Life Centre
    Station Road
    SN1 1EL Swindon
    Wiltshire
    British117273030002
    SANDERS, Stephen Robin
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    Secretario
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    British38839120001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secretario designado corporativo
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BAILEY, Charles Howard
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    Director
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    United KingdomBritish1992450001
    BATES, Sarah Catherine
    12 Alwyne Place
    N1 2NL London
    Director
    12 Alwyne Place
    N1 2NL London
    United KingdomBritish65874310002
    BAZALGETTE, Vivian Paul
    Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    United Kingdom
    Director
    Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish69074010001
    BELLAMY, David Charles
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    Director
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish84428640001
    BRADSHAW, Paul Richard
    5 South End Close
    Hursley
    SO21 2LJ Winchester
    Hampshire
    Director
    5 South End Close
    Hursley
    SO21 2LJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish47181430001
    BURKE, Dominic James
    GL7 1FP Cirencester, Gloucestershire
    St. James's Place House, 1 Tetbury Road
    United Kingdom
    Director
    GL7 1FP Cirencester, Gloucestershire
    St. James's Place House, 1 Tetbury Road
    United Kingdom
    United KingdomBritish256291010003
    COLSELL, Steven James
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    EnglandBritish101387770001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    Director
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    CORNISH, Iain Charles Andrew
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    Glos
    United Kingdom
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St James's Place House
    Glos
    United Kingdom
    United KingdomBritish66522190006
    CROFT, Andrew Martin
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish55940940004
    CROSBY, James Robert, Sir
    Glendevon House
    Howhill Road, Beckwithshaw
    HG3 1QJ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Glendevon House
    Howhill Road, Beckwithshaw
    HG3 1QJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandUk18867860005
    DAWSON, Joanne
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Director
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    British112053530004
    D`URSO, Mario
    Viale Di Villa
    Grazioli 4/A
    00198 Rome
    Italy
    Director
    Viale Di Villa
    Grazioli 4/A
    00198 Rome
    Italy
    Italian57386290001
    EDWARDS, John Stephen
    Ebbor House
    Wookey Hole
    BA5 1AY Wells
    Somerset
    Director
    Ebbor House
    Wookey Hole
    BA5 1AY Wells
    Somerset
    British143155400001
    GASCOIGNE, Ian Stewart
    Tennis Drive
    The Park
    NG7 1AE Nottingham
    19
    United Kingdom
    Director
    Tennis Drive
    The Park
    NG7 1AE Nottingham
    19
    United Kingdom
    United KingdomBritish54370650002
    GENTLE, Craig Gordon
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    Director
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    EnglandBritish241604310001

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0