SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03188573 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pendragon House 65 London Road AL1 1LJ St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 ene 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 ene 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 ene 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 13 ene 2026 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Alan James Curtis el 06 nov 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Market Place Brackley NN13 7AB England a Pendragon House 65 London Road St. Albans Hertfordshire AL1 1LJ el 18 nov 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2025 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2024 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2023 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 nov 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Notification de Neil Curtis en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2023 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Cre Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2020 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 7 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Alan James Curtis como director el 13 mar 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 9 Market Place Brackley Northamptonshire NN13 7AB United Kingdom a 1 Market Place Market Place Brackley NN13 7AB el 10 mar 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 abr 2019 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 9 Market Place Brackley Northamptonshire AL13 7AB England a 9 Market Place Brackley Northamptonshire NN13 7AB el 25 ene 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mr Neil Carl Curtis como secretario el 18 dic 2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Modification des détails de Cre Asset Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 dic 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
¿Quiénes son los directivos de SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURTIS, Neil Carl | Secretario | Seymour Road AL3 5HN St. Albans 25 England | 254514840001 | |||||||||||
| CURTIS, Alan James | Director | 65 London Road AL1 1LJ St. Albans Pendragon House Hertfordshire England | England | British | 178560260001 | |||||||||
| CURTIS, Neil Carl | Director | Seymour Road AL3 5HN St. Albans 25 England | England | British | 133133980002 | |||||||||
| BLEASE, Elizabeth Ann | Secretario | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House United Kingdom | 168774090001 | |||||||||||
| CHAPMAN, Julia Jacquetta Caroline | Secretario | River Lea Moor End, Acaster Malbis YO23 2UH York North Yorkshire | English | 68697650002 | ||||||||||
| COPE, Graham Anthony | Secretario | Turnberry House 12 Swallow Drive CW6 0GD Kelsall Cheshire | British | 85842880003 | ||||||||||
| DAVIES, Helen | Secretario | 14 Cae Haf CH7 6GB Northop Hall Flintshire | British | 83638070001 | ||||||||||
| FERNANDEZ, Michelle | Secretario | 1 Milesmere Two Mile Ash MK8 8DP Milton Keynes Buckinghamshire | British | 98129630001 | ||||||||||
| MCCARTHY, Anne Patricia | Secretario | 46 Torcross Road HA4 0TD South Ruislip Middlesex | British | 8702280009 | ||||||||||
| SPARKS, Raymond Richard | Secretario | 19 Queens Road Byfleet KT14 7AD West Byfleet Surrey | British | 35662370002 | ||||||||||
| THOMAS, Howard | Secretario designado | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | 900000900001 | ||||||||||
| WALKER, Rhiannon Ellis | Secretario | Gatesheath Hall Gatesheath Tattenhall CH3 9AH Chester Cheshire | British | 86070003 | ||||||||||
| HERMES SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers United Kingdom |
| 93700910001 | ||||||||||
| BRADFORD, Douglas Philip | Director | 47 Grove Avenue Muswell Hill N10 2AL London | England | British | 5242960002 | |||||||||
| CHAPMAN, Julia Jacquetta Caroline | Director | River Lea Moor End, Acaster Malbis YO23 2UH York North Yorkshire | England | English | 68697650002 | |||||||||
| CHARLTON, John Michael | Director | Dunstone 5 Broomfield Ride KT22 0LR Oxshott Surrey | England | British | 73081460001 | |||||||||
| DODDS, Stephen Christopher | Director | 10 Manor Rise WS14 9SL Lichfield Staffordshire | British | 44249590002 | ||||||||||
| EDWARDS, Nicholas William John | Director | c/o Moorfield Group Limited 65 Curzon Street W1J 8PE London Nightingale House England | England | British | 166575000001 | |||||||||
| GEE, David John | Director | The Hatch Churt GU10 2NV Farnham Surrey | United Kingdom | British | 43451240002 | |||||||||
| GIARD, Laurence Yolande | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House United Kingdom | France | French | 166569010001 | |||||||||
| GILLETT, Philip John | Director | Cedar House Rockfield Road RH8 0EJ Oxted Surrey | United Kingdom | British | 6838010001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Andrew Donald | Director | Cruck House 38 Main Street LE6 0AD Newton Linford Leicestershire | United Kingdom | British | 56528380003 | |||||||||
| GROSE, David Leonard | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House United Kingdom | United Kingdom | British | 120479020002 | |||||||||
| HILL, Malcolm William | Director | Greystones Gorsedd CH8 8QY Holywell Flintshire | British | 22045170001 | ||||||||||
| HOLLAND, Jonathan Robert William | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House United Kingdom | United Kingdom | British | 122543480002 | |||||||||
| ISHERWOOD, Simon Martin | Director | 15 Willow Green WA16 6AX Knutsford Cheshire | British | 56333750001 | ||||||||||
| JONES, Richard William | Director | 18 Fairford Avenue LU2 7ER Luton | United Kingdom | British | 74514660002 | |||||||||
| MCGIVERN, Jayne Eleanor | Director | Greenlands Farm Barber Booth Edale S33 7ZL Hope Valley Derbyshire | England | British | 42265220002 | |||||||||
| NOAKES, Colin | Director | 61 Hengistbury Road BH6 4DJ Southbourne Bournemouth | British | 70199390001 | ||||||||||
| OSBORN, Gareth John | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 258 | England | British | 91257750004 | |||||||||
| PILSWORTH, Andrew John | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House | United Kingdom | British | 155293090003 | |||||||||
| RADDER, Helmut Kurt Hans | Director | Flat F 11 Queens Gate Terrace SW7 5PR London | German | 73769570001 | ||||||||||
| REDWOOD, Nicholas Paul Kenneth | Director | Avenue Road AL1 3QQ St Albans 6 Hertfordshire | United Kingdom | British | 107118750001 | |||||||||
| SIDWELL, Graham Robert | Director | Nightingale House, 65 Curzon Street W1J 8PE London C/O Moorfield Group Limited England | United Kingdom | British | 72844280004 | |||||||||
| SPALL, Alan George | Director | Fairacre The Drive Wonersh Park Wonersh GU5 0QW Guildford Surrey | British | 14624980004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SEVERNSIDE DISTRIBUTION PARK (BRISTOL) MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Neil Carl Curtis | 01 nov 2023 | Seymour Road AL3 5HN St. Albans 25 England | No | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Cre Asset Management Limited | 18 dic 2018 | Market Place NN13 7AB Brackley 9 England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Uk Logistics (Nominee 1) Limited | 06 abr 2016 | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| The Uk Logistics (Nominee 2) Limited | 06 abr 2016 | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0