VICTORY CORPORATION LIMITED

VICTORY CORPORATION LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVICTORY CORPORATION LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03189714
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VICTORY CORPORATION LIMITED?

    • (5233) /
    • (5242) /

    ¿Dónde se encuentra VICTORY CORPORATION LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Cantium House
    Railway Approach
    SM6 0DZ Wallington
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VICTORY CORPORATION LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VICTORY CORPORATION PLC07 oct 199607 oct 1996
    ISSUETIMED PUBLIC LIMITED COMPANY23 abr 199623 abr 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VICTORY CORPORATION LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VICTORY CORPORATION LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    12 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 sept 2012

    13 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 15 sept 2011

    13 páginas4.68

    Resultado de la reunión de acreedores

    3 páginas2.23B

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Alexander Green Curzon House 64 Clifton Street London EC24 4HB el 27 sept 2010

    2 páginasAD01

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    32 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 27 mar 2010

    28 páginas2.24B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.15B/2.14B

    7 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    25 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de Salisbury House City Fields Business Park Tangmere Chichester West Sussex PO20 2FP United Kingdom el 18 oct 2009

    1 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    legacy

    4 páginas395

    legacy

    2 páginas403a

    legacy

    2 páginas403a

    legacy

    2 páginas403a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas403a

    legacy

    3 páginas395

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    17 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re: directors conflict of interests 10/10/2008
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de VICTORY CORPORATION LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RATANKUMAR, Daryani
    Suffolk Road
    HA2 7QF Harrow
    57
    Middlesex
    Secretario
    Suffolk Road
    HA2 7QF Harrow
    57
    Middlesex
    BritishCompany Director136155360001
    RATANKUMAR, Daryani
    Suffolk Road
    HA2 7QF Harrow
    57
    Middlesex
    Director
    Suffolk Road
    HA2 7QF Harrow
    57
    Middlesex
    BritishCompany Director136155360001
    SIMMONS, Rosalind Ann
    Lydwicke Lodge
    Hayes Lane
    RH13 0RF Slinfold
    West Sussex
    Director
    Lydwicke Lodge
    Hayes Lane
    RH13 0RF Slinfold
    West Sussex
    EnglandBritishManaging Director49977340001
    BAYLISS, Joshua
    15 Hopefield Avenue
    NW6 6LJ London
    Secretario
    15 Hopefield Avenue
    NW6 6LJ London
    British114409340001
    DIXON, Craig Stephen
    Florian House
    Leatherhead Road
    KT22 0ET Oxshott
    Surrey
    Secretario
    Florian House
    Leatherhead Road
    KT22 0ET Oxshott
    Surrey
    BritishFinance Director105534460001
    GERRARD, Barry Alexander Ralph
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    Secretario
    50 Brook Green
    Hammersmith
    W6 7RR London
    The School House
    United Kingdom
    British188290005
    GRAM, Peter Gerardus
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    Secretario
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    British67245530001
    KNIGHT, Richard Hugh
    Feather Sound 1 Hillgarth
    GU26 6PP Hindhead
    Surrey
    Secretario
    Feather Sound 1 Hillgarth
    GU26 6PP Hindhead
    Surrey
    British57392500001
    LASCELLES, Shaun William
    19 Narcissus Road
    NW6 1TJ London
    Secretario
    19 Narcissus Road
    NW6 1TJ London
    BritishSolicitor72571650003
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Secretario
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRUCE, Clive
    The White House
    High Street
    BN16 4AH Angmering
    West Sussex
    Director
    The White House
    High Street
    BN16 4AH Angmering
    West Sussex
    EnglandBritishGroup Commercial Director116589550001
    DARYANI, Ratankumar
    Suffolk Road
    HA2 7QF Harrow
    57
    Middlesex
    Director
    Suffolk Road
    HA2 7QF Harrow
    57
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director49132730002
    DIXON, Craig Stephen
    Florian House
    Leatherhead Road
    KT22 0ET Oxshott
    Surrey
    Director
    Florian House
    Leatherhead Road
    KT22 0ET Oxshott
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director105534460001
    GLASGOW, Simon Lawrence
    Taw House Wilton Lane
    Jordans
    HP9 2UW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Taw House Wilton Lane
    Jordans
    HP9 2UW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChief Executive75169830001
    JACKSON, John Ellis
    Avalon 26 Abbey Gardens
    Upper Woolhampton
    RG7 5TZ Reading
    Berkshire
    Director
    Avalon 26 Abbey Gardens
    Upper Woolhampton
    RG7 5TZ Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director2219540003
    KNIGHT, Richard Hugh
    Feather Sound 1 Hillgarth
    GU26 6PP Hindhead
    Surrey
    Director
    Feather Sound 1 Hillgarth
    GU26 6PP Hindhead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector57392500001
    LASCELLES, Shaun William
    19 Narcissus Road
    NW6 1TJ London
    Director
    19 Narcissus Road
    NW6 1TJ London
    BritishSolicitor72571650003
    LEE, Andrew Shore
    Elmwood Avenue
    PO22 8DE Bognor Regis
    21
    West Sussex
    Director
    Elmwood Avenue
    PO22 8DE Bognor Regis
    21
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant131320710001
    MCCALL, Patrick Charles Kingdon
    Campden Hill Road
    W8 7AR London
    120
    Director
    Campden Hill Road
    W8 7AR London
    120
    BritishCorporate Operations Director81875070005
    MCCALL, Patrick Charles Kingdon
    Bartons
    Stoughton
    PO18 9JQ Chichester
    West Sussex
    Director
    Bartons
    Stoughton
    PO18 9JQ Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishCorporate Operations Director81875070004
    MCCARTHY, Rory Clement
    47 Addison Road
    W14 8JH London
    Director
    47 Addison Road
    W14 8JH London
    IrishCompany Director71895700002
    MCCARTHY, Timothy
    Old St.James' Vicarage
    Maxwell Road
    SW6 2HR London
    Director
    Old St.James' Vicarage
    Maxwell Road
    SW6 2HR London
    IrishCompany Director65347050001
    MURPHY, Stephen Thomas Matthew
    The Garden House
    11 Withdean Road
    BN1 5BL Brighton
    East Sussex
    Director
    The Garden House
    11 Withdean Road
    BN1 5BL Brighton
    East Sussex
    BritishAccountant70496800006
    MURPHY, Stephen Thomas Matthew
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    Director
    23 The Crescent
    SW13 0NN London
    BritishAccountant70496800002
    PLUTHERO, Ian Raymond
    2 Galane Close
    West Hunsbury
    NN4 9YR Northampton
    Director
    2 Galane Close
    West Hunsbury
    NN4 9YR Northampton
    BritishDirector66321570002
    ROGERS, John Leonard
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    Director
    The Old House
    The Square
    NN6 9SD Hannington
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector19597130001
    ROSSER, Bradley John
    10a Redburn Street
    SW3 4BX London
    Director
    10a Redburn Street
    SW3 4BX London
    AustralianCorp Dev Dir48382100001
    ROSSER, Bradley John
    10a Redburn Street
    SW3 4BX London
    Director
    10a Redburn Street
    SW3 4BX London
    AustralianCorp Developer48382100001
    RUTHERFORD, David John
    3 Cropthorne Drive
    BN17 5GG Climping
    West Sussex
    Director
    3 Cropthorne Drive
    BN17 5GG Climping
    West Sussex
    EnglandBritishFinance Director166439810001
    STILES, Duncan Robert
    Flat 3 110 Huron Road
    SW17 8RD London
    Director
    Flat 3 110 Huron Road
    SW17 8RD London
    BritishSolicitor69748680002
    THOMAS, Barbara, Lady
    St James's Street
    SW1A 1HD London
    33
    Director
    St James's Street
    SW1A 1HD London
    33
    AmericanCompany Director88709030001
    VON GREYERZ, Egon
    The Oaks
    Letty Green
    SG14 2NZ Hertford
    Director
    The Oaks
    Letty Green
    SG14 2NZ Hertford
    SwissDirector71638600001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Director designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    ¿Tiene VICTORY CORPORATION LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 06 may 2009
    Entregado el 09 may 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 09 may 2009Registro de un cargo (395)
    Security agreement
    Creado el 31 oct 2008
    Entregado el 07 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge all properties acquired, property interests, equipment, securities intellectual property, debts accounts, goodwill and uncalled capital see image for full details.
    Personas con derecho
    • Victory Acquisitions Limited
    Transacciones
    • 07 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 18TH february 1999
    Creado el 14 oct 2002
    Entregado el 23 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and liabilities due or to become due from either the company or any one or more of the other parties to the agreement (other than the bank) to the chargee
    Breve descripción
    All sum or sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 mar 2002
    Entregado el 10 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Barfair Limited
    Transacciones
    • 10 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 ene 2000
    Entregado el 27 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 27 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 13 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement creating charge over securities and cash
    Creado el 02 sept 1999
    Entregado el 08 sept 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The securities as specified in the schedule to the security agreement (the "original securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 sept 1999Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene VICTORY CORPORATION LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    16 sept 2010Fin de la administración
    28 sept 2009Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Hasan Imam Mirza
    Agassociates Cantium House Railway Approach
    Wallington
    SM6 0HB Surrey
    Profesional
    Agassociates Cantium House Railway Approach
    Wallington
    SM6 0HB Surrey
    2
    FechaTipo
    04 jul 2013Fecha de disolución
    16 sept 2010Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Hasan Imam Mirza
    Cantium House Railway Approach
    SM6 0DZ Wallington
    Surrey
    Profesional
    Cantium House Railway Approach
    SM6 0DZ Wallington
    Surrey

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0