SCEPTRE LEISURE PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSCEPTRE LEISURE PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 03189747
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SCEPTRE LEISURE PLC?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra SCEPTRE LEISURE PLC?

    Dirección de la sede social
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SCEPTRE LEISURE PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GAMINGKING PLC25 sept 200225 sept 2002
    THEBIZ.COM PLC25 abr 200025 abr 2000
    LOTTERYKING HOLDINGS PLC27 jun 199627 jun 1996
    TRACKSTAKE PUBLIC LIMITED COMPANY23 abr 199623 abr 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SCEPTRE LEISURE PLC?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 abr 2014
    Próximas cuentas vencen el31 oct 2014
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SCEPTRE LEISURE PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 07 feb 2017

    40 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 21 jul 2016

    47 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 21 ene 2016

    46 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 10 ago 2015

    45 páginas2.24B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    74 páginas2.16B

    Cese del nombramiento de Kenneth Bryan Turner como director el 24 mar 2015

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 139 Brookfield Place, Walton Summit Centre Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 8BF England a The Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW el 10 abr 2015

    2 páginasAD01

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    100 páginas2.17B

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cese del nombramiento de Kenneth William Lawrence como director el 09 ene 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Moshe Barak como director el 16 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lars Felderhoff como director el 04 dic 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jeremy Charles Wilson como director el 02 nov 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2014 avec liste globale des actionnaires

    19 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ago 2014

    Estado de capital el 18 ago 2014

    • Capital: GBP 2,849,479.2
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 abr 2013

    46 páginasAA

    Cese del nombramiento de Shmuel Weiss como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Kenneth William Lawrence como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Lars Felderhoff como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Victor Wardman como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Shmuel Weiss como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2013, aucune liste de membres fournie

    9 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jun 2013

    Estado de capital el 21 jun 2013

    • Capital: GBP 2,849,479.2
    SH01

    Cese del nombramiento de Douglas Yates como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SCEPTRE LEISURE PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WHITE, Mark Adrian Franklin
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Secretario
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    178828920001
    WHITE, Mark Adrian Franklin
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    Director
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery
    United KingdomBritish156106020001
    ELLIS, Philip David
    32 Upcroft Avenue
    HA8 9RB Edgware
    Middlesex
    Secretario
    32 Upcroft Avenue
    HA8 9RB Edgware
    Middlesex
    English58819760001
    GOWING, Sarah Jean
    38 Downing Court
    CB5 0LP Swaffham Bulbeck
    Cambrigeshire
    Secretario
    38 Downing Court
    CB5 0LP Swaffham Bulbeck
    Cambrigeshire
    British106780140001
    WILLIAMS, Nigel Lawrence
    25 Gilbert Road
    RM16 6NN Grays
    Essex
    Secretario
    25 Gilbert Road
    RM16 6NN Grays
    Essex
    British70522210001
    ZWANENBERG, Guy Christopher Van
    Mole End Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    Mole End Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British33929370001
    ZWANENBERG, Guy Christopher Van
    Mole End Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    Mole End Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British33929370001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Secretario corporativo
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    VZ LIMITED
    Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley-On-Thames
    Mole End
    Oxfordshire
    England
    Secretario corporativo
    Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley-On-Thames
    Mole End
    Oxfordshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2598613
    160283600001
    BARAK, Moshe
    Brookfield Place, Walton Summit Centre
    Bamber Bridge
    PR5 8BF Preston
    139
    Lancashire
    England
    Director
    Brookfield Place, Walton Summit Centre
    Bamber Bridge
    PR5 8BF Preston
    139
    Lancashire
    England
    IsraelIsraeli178829520001
    ELLIS, Philip David
    32 Upcroft Avenue
    HA8 9RB Edgware
    Middlesex
    Director
    32 Upcroft Avenue
    HA8 9RB Edgware
    Middlesex
    EnglandEnglish58819760001
    FELDERHOFF, Lars
    Merkur-Allee 1-15
    D-32339
    Espelkamp
    Gauselmann Ag
    Germany
    Director
    Merkur-Allee 1-15
    D-32339
    Espelkamp
    Gauselmann Ag
    Germany
    GermanyGerman182164690001
    GARE, Michael Adrian
    Rowe & Maw
    20 Blackfriars Lane
    EC4V 6HD London
    Director
    Rowe & Maw
    20 Blackfriars Lane
    EC4V 6HD London
    United KingdomBritish86799370002
    HUMPHRYS, Lesley Susan
    7 Lodge Wood Close
    PR7 2FL Chorley
    Lancashire
    Director
    7 Lodge Wood Close
    PR7 2FL Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish77719250002
    HURST, Leslie Ronald
    17 North Avenue
    Ealing
    W13 8AP London
    Director
    17 North Avenue
    Ealing
    W13 8AP London
    EnglandBritish33231000003
    LAWRENCE, Kenneth William
    The Headway
    KT17 1UJ Epsom
    4
    Surrey
    England
    Director
    The Headway
    KT17 1UJ Epsom
    4
    Surrey
    England
    United KingdomBritish40388380001
    NICHOLS, Brian Albert
    Cartrefle 10 Ashdown Close
    Great Notley
    CM7 8FR Braintree
    Essex
    Director
    Cartrefle 10 Ashdown Close
    Great Notley
    CM7 8FR Braintree
    Essex
    United KingdomBritish74492110001
    SANDERSON, John Frederick Waley
    6 Highbury Hill
    N5 1AL London
    Director
    6 Highbury Hill
    N5 1AL London
    EnglandBritish4764150001
    SPEAK, Andrew Aitchison
    Hill House
    Eaton Park
    KT11 2JE Cobham
    Surrey
    Director
    Hill House
    Eaton Park
    KT11 2JE Cobham
    Surrey
    British29891910003
    STACK, Alan Maurice
    Fambridge
    22 Ridgeway Hutton
    CM13 2LP Brentwood
    Essex
    Director
    Fambridge
    22 Ridgeway Hutton
    CM13 2LP Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish65330930002
    STACK, Barry Michael
    Corner Cottage
    Vicarage Lane
    IG7 6LX Chigwell
    Essex
    Director
    Corner Cottage
    Vicarage Lane
    IG7 6LX Chigwell
    Essex
    British40244630001
    TURNER, Kenneth Bryan
    Lynton Longsight Road
    Clayton Le Dale
    BB2 7JA Blackburn
    Lancashire
    Director
    Lynton Longsight Road
    Clayton Le Dale
    BB2 7JA Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish29183950001
    WARDMAN, Victor
    Oakfield
    Weston
    SY4 5XA Shrewsbury
    Salop
    Director
    Oakfield
    Weston
    SY4 5XA Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritish64871090001
    WATKINS, Nicholas Revely
    The Hall
    Broad Street, East Ilsley
    RG20 7LW Newbury
    Berkshire
    Director
    The Hall
    Broad Street, East Ilsley
    RG20 7LW Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish41696760002
    WEISS, Shmuel
    Brookfield Place, Walton Summit Centre
    Bamber Bridge
    PR5 8BF Preston
    139
    Lancashire
    England
    Director
    Brookfield Place, Walton Summit Centre
    Bamber Bridge
    PR5 8BF Preston
    139
    Lancashire
    England
    IsraelIsraeli180038840001
    WHITE, Mark
    14a Mortlock Street
    Melbourn
    SG8 6DB Royston
    Hertfordshire
    Director
    14a Mortlock Street
    Melbourn
    SG8 6DB Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish118331900002
    WILLIAMS, Nigel Lawrence
    25 Gilbert Road
    RM16 6NN Grays
    Essex
    Director
    25 Gilbert Road
    RM16 6NN Grays
    Essex
    United KingdomBritish70522210001
    WILSON, Jeremy Charles
    c/o Chenavari Investment Managers
    Grosvenor Place
    SW1X 7JH London
    1
    England
    Director
    c/o Chenavari Investment Managers
    Grosvenor Place
    SW1X 7JH London
    1
    England
    United KingdomBritish156549430001
    YATES, Douglas Martin
    Aldbury
    29 Grange Gardens
    HA5 5QD Pinner
    Middlesex
    Director
    Aldbury
    29 Grange Gardens
    HA5 5QD Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish1323520001
    ZWANENBERG, Guy Christopher Van
    Mole End Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Mole End Crowsley Road
    Shiplake
    RG9 3LD Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish33929370001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Director corporativo
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    NIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    WDC 6NOC London
    Director corporativo
    50 Stratton Street
    WDC 6NOC London
    48389320001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Director designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    ¿Tiene SCEPTRE LEISURE PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 09 may 2013
    Entregado el 14 may 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Auster Real Estate Opportunities Sarl (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 14 may 2013Registro de una carga (MR01)
    Chattel mortgage
    Creado el 26 feb 2011
    Entregado el 10 mar 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The chattels and the documents including all engines, appliances, parts, spare parts, components, instruments, appurtenances, accessories and other equipment see image for full details.
    Personas con derecho
    • Aldermore Bank PLC
    Transacciones
    • 10 mar 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 15 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of assignment of life policy
    Creado el 02 mar 2010
    Entregado el 11 mar 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Right title and interest in the policy of assurance or insurance of the life of kenneth bryan turner for the sum of £500,000.00 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotalnd PLC
    Transacciones
    • 11 mar 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 15 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 oct 2008
    Entregado el 21 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 15 may 2007
    Entregado el 25 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 10 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SCEPTRE LEISURE PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    07 feb 2017Fin de la administración
    11 feb 2015Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Profesional
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Phillip Francis Duffy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Profesional
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0