PTIS 2011 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PTIS 2011 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03190628 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PTIS 2011 LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra PTIS 2011 LIMITED?
Dirección de la sede social | Thornburgh Road Eastfield YO11 3UY Scarborough North Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PTIS 2011 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
PINDAR TRAVEL INFORMATION SYSTEMS LTD. | 20 jun 2000 | 20 jun 2000 |
PINDAR ROUTEL LIMITED | 11 jul 1996 | 11 jul 1996 |
PINDAR ROUTELL LIMITED | 05 jul 1996 | 05 jul 1996 |
CROCKVILLE LIMITED | 25 abr 1996 | 25 abr 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PTIS 2011 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PTIS 2011 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 abr 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Jenna Holliday como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Aviso de cambio de nombre | 2 páginas | CONNOT | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 abr 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 abr 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Elizabeth Caroline Pindar el 31 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Dalton como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Jenna Louise Holliday el 31 mar 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr George Andrew Pindar como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 4 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2008 | 3 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2007 | 3 páginas | AA |
¿Quiénes son los directivos de PTIS 2011 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINDAR, Elizabeth Caroline | Director | Thornburgh Road Eastfield YO11 3UY Scarborough North Yorkshire | England | British | Chartered Civil Engineer | 55070660002 | ||||
PINDAR, George Andrew | Director | Thornburgh Road Eastfield YO11 3UY Scarborough North Yorkshire | England | British | Printer | 1120570003 | ||||
BARKER, Jack | Secretario | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | Solicitors Clerk | 34404400001 | |||||
DWYER, Daniel John | Secretario designado | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
HOLLIDAY, Jenna Louise | Secretario | Thornburgh Road Eastfield YO11 3UY Scarborough North Yorkshire | British | 136386570001 | ||||||
NOAKES, David Anthony | Secretario | 21 Town Street Old Malton YO17 7HB Malton North Yorkshire | British | 54380850004 | ||||||
WOOLLEY, Heather Caroline | Secretario | 25 Mayville Avenue YO12 7NW Scarborough North Yorkshire | British | 38563500003 | ||||||
BARKER, Jack | Director | 21 Silverdale Drive Guiseley LS20 8BE Leeds West Yorkshire | British | Solicitors Clerk | 34404400001 | |||||
DALTON, Andrew Leslie | Director | Kirby House Farm Kirby Knowle YO7 2JF Thirsk North Yorkshire | England | British | Chief Executive | 116104960001 | ||||
DALTON, Andrew Leslie | Director | East Lodge Upsall YO7 2QH Thirsk North Yorkshire | British | Chief Executive | 8484940001 | |||||
DOYLE, Betty June | Director designado | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
DUGGLEBY, Paul Neil | Director | 42 The Oaks Walton Le Dale PR5 4LT Preston | British | Company Director | 42924780003 | |||||
DWYER, Daniel John | Director designado | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
FRAWLEY, R Douglas | Director | 70 Box Hill YO12 5NG Scarborough North Yorkshire | Canadian | Sales & Marketing Director | 72180890001 | |||||
FROUD, Keith | Director | 12 Cavalier Drive Apperley Bridge BD10 0UF Bradford West Yorkshire | British | Solicitor | 54853670002 | |||||
LUMBY, Richard Stephen | Director | The Nabs Scalby Nabs Scalby YO13 0SL Scarborough North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 5653290002 | ||||
MCCARTHY, John | Director | 34 Beechwood Rise LS22 7QT Wetherby West Yorkshire | British | Sales Director | 76184180001 | |||||
O'SULLIVAN, Paul Joseph | Director | Robin Hill Ravenscar Y013 ONA Scarborough North Yorkshire | British | Chief Executive | 39741380001 | |||||
PALFREY, David Gwyn | Director | Bay Horse Cottage 19 Main Street Ebberston YO13 9NR Scarborough North Yorkshire | British | Director | 1209930001 | |||||
SHANKS, Patrick Gerald Christian | Director | Campion House Pickering Road West, Snainton YO13 9PL Scarborough North Yorkshire | British | Director | 70518820001 | |||||
WHEELER, Andrew John | Director | 1 Hempland Avenue Stockton Lane YO31 1DB York North Yorkshire | British | Production Director | 74427140001 | |||||
WILKINSON, Peter James | Director | Bridgewater House 16 Station Road Scalby YO13 0PU Scarborough | England | British | Marketing House | 70519070001 |
¿Tiene PTIS 2011 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 11 feb 2000 Entregado el 15 feb 2000 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0