PTIS 2011 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPTIS 2011 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03190628
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PTIS 2011 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PTIS 2011 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PTIS 2011 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PINDAR TRAVEL INFORMATION SYSTEMS LTD.20 jun 200020 jun 2000
    PINDAR ROUTEL LIMITED11 jul 199611 jul 1996
    PINDAR ROUTELL LIMITED05 jul 199605 jul 1996
    CROCKVILLE LIMITED25 abr 199625 abr 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PTIS 2011 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PTIS 2011 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 25 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 may 2012

    Estado de capital el 01 may 2012

    • Capital: GBP 62
    SH01

    Cese del nombramiento de Jenna Holliday como secretario

    1 páginasTM02

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 02 ago 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 27 jul 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Elizabeth Caroline Pindar el 31 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Andrew Dalton como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Jenna Louise Holliday el 31 mar 2010

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Mr George Andrew Pindar como director

    2 páginasAP01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    2 páginas288a

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2008

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas preparadas hasta el 30 sept 2007

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PTIS 2011 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PINDAR, Elizabeth Caroline
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Civil Engineer55070660002
    PINDAR, George Andrew
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishPrinter1120570003
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secretario designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    HOLLIDAY, Jenna Louise
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    Thornburgh Road
    Eastfield
    YO11 3UY Scarborough
    North Yorkshire
    British136386570001
    NOAKES, David Anthony
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    Secretario
    21 Town Street
    Old Malton
    YO17 7HB Malton
    North Yorkshire
    British54380850004
    WOOLLEY, Heather Caroline
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    25 Mayville Avenue
    YO12 7NW Scarborough
    North Yorkshire
    British38563500003
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    DALTON, Andrew Leslie
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    Director
    Kirby House Farm
    Kirby Knowle
    YO7 2JF Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritishChief Executive116104960001
    DALTON, Andrew Leslie
    East Lodge
    Upsall
    YO7 2QH Thirsk
    North Yorkshire
    Director
    East Lodge
    Upsall
    YO7 2QH Thirsk
    North Yorkshire
    BritishChief Executive8484940001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Director designado
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DUGGLEBY, Paul Neil
    42 The Oaks
    Walton Le Dale
    PR5 4LT Preston
    Director
    42 The Oaks
    Walton Le Dale
    PR5 4LT Preston
    BritishCompany Director42924780003
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Director designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FRAWLEY, R Douglas
    70 Box Hill
    YO12 5NG Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    70 Box Hill
    YO12 5NG Scarborough
    North Yorkshire
    CanadianSales & Marketing Director72180890001
    FROUD, Keith
    12 Cavalier Drive
    Apperley Bridge
    BD10 0UF Bradford
    West Yorkshire
    Director
    12 Cavalier Drive
    Apperley Bridge
    BD10 0UF Bradford
    West Yorkshire
    BritishSolicitor54853670002
    LUMBY, Richard Stephen
    The Nabs Scalby Nabs
    Scalby
    YO13 0SL Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The Nabs Scalby Nabs
    Scalby
    YO13 0SL Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director5653290002
    MCCARTHY, John
    34 Beechwood Rise
    LS22 7QT Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    34 Beechwood Rise
    LS22 7QT Wetherby
    West Yorkshire
    BritishSales Director76184180001
    O'SULLIVAN, Paul Joseph
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Robin Hill
    Ravenscar
    Y013 ONA Scarborough
    North Yorkshire
    BritishChief Executive39741380001
    PALFREY, David Gwyn
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Bay Horse Cottage
    19 Main Street Ebberston
    YO13 9NR Scarborough
    North Yorkshire
    BritishDirector1209930001
    SHANKS, Patrick Gerald Christian
    Campion House
    Pickering Road West, Snainton
    YO13 9PL Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    Campion House
    Pickering Road West, Snainton
    YO13 9PL Scarborough
    North Yorkshire
    BritishDirector70518820001
    WHEELER, Andrew John
    1 Hempland Avenue
    Stockton Lane
    YO31 1DB York
    North Yorkshire
    Director
    1 Hempland Avenue
    Stockton Lane
    YO31 1DB York
    North Yorkshire
    BritishProduction Director74427140001
    WILKINSON, Peter James
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    Director
    Bridgewater House 16 Station Road
    Scalby
    YO13 0PU Scarborough
    EnglandBritishMarketing House70519070001

    ¿Tiene PTIS 2011 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 11 feb 2000
    Entregado el 15 feb 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 15 feb 2000Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0