GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03191236 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED?
- Otras actividades recreativas y de entretenimiento n.c.p. (93290) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | Parkwood House Cuerden Park Berkeley Drive PR5 6BY Bamber Bridge Preston Lancashire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| THE SECRET CITY COMPANY LIMITED | 29 may 1996 | 29 may 1996 |
| SPEED 5572 LIMITED | 26 abr 1996 | 26 abr 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mike John Quayle el 28 feb 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony William Hewitt como director el 02 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Harvey Brunskill como director el 02 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 26 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 abr 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Anthony William Hewitt como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carolyn Stockdale como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 abr 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 18 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Cambio de datos del director Mike John Quayle el 28 jul 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Heather Rosling como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNSKILL, Michael Harvey | Director | Parkwood House Cuerden Park Berkeley Drive PR5 6BY Bamber Bridge Preston Lancashire | England | British | 150264900002 | |||||
| QUAYLE, Mike John | Director | Parkwood House Cuerden Park Berkeley Drive PR5 6BY Bamber Bridge Preston Lancashire | England | British | 95332960002 | |||||
| BITHELL, Charles Peter | Secretario | The Hawthorns 78 The Common Parbold WN8 7EA Wigan Lancashire | British | 70732940003 | ||||||
| BOWMAN, Terence Patrick Edward | Secretario | Apartment 11 Ryburn Barkisland Mill Beestonley Lane HX4 0AG Halifax West Yorkshire | British | 127543040001 | ||||||
| BOWMAN, Terence Patrick Edward | Secretario | Apartment 11 Ryburn Barkisland Mill Beestonley Lane HX4 0AG Halifax West Yorkshire | British | 127543040001 | ||||||
| BOWMAN, Terence Patrick | Secretario | 71 Adelaide Road Bramhall SK7 1NP Stockport Cheshire | British | 38608490002 | ||||||
| BURNS, Norah Jane Jacinta | Secretario | 78 Kilworth Drive Lostock BL6 4RL Bolton Lancashire | British | 114059940002 | ||||||
| EADIE, Douglas Young | Secretario | 18 Chalfont Close Appleton WA4 5JT Warrington Cheshire | British | 67308860001 | ||||||
| LEE, Edwin Robert | Secretario | Rowde House High Street Rowde SN10 2ND Devizes Wiltshire | British | 29818200001 | ||||||
| NG, Nadine Loon Angela | Secretario | 1 Lumwood Smithills BL1 6TZ Bolton Lancashire | British | 28959860001 | ||||||
| NG, Nadine Loon Angela | Secretario | 1 Lumwood Smithills BL1 6TZ Bolton Lancashire | British | 28959860001 | ||||||
| ROSLING, Heather Anne | Secretario | Green Walk Gatley SK8 4BW Stockport 42 Cheshire Uk | British | 154873200001 | ||||||
| STOCKDALE, Carolyn | Secretario | Beacon View Appley Bridge WN6 9AJ Wigan 6 Lancashire | British | 130249010003 | ||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| HEWITT, Anthony William | Director | Alston Lane PR3 3BN Preston Alston Old Hall Farm Lancashire United Kingdom | England | British | 130793730001 | |||||
| HEWITT, Anthony William | Director | Alston Lane Longridge PR3 3BN Preston Alston Old Hall Lancashire | England | British | 130793730001 | |||||
| HEWITT, Anthony William | Director | Alston Lane Longridge PR3 3BN Preston Alston Old Hall Lancashire | England | British | 130793730001 | |||||
| HOLT, Andrew Guest | Director | Kempsey Lodge Oakfield Close WR5 3PR Kempsey Worcestershire | England | British | 49277480004 | |||||
| JONES, Larry | Director | 17 The Grove Little Aston B74 3UB Sutton Coldfield West Midlands | British | 60614870004 | ||||||
| LEE, Edwin Robert | Director | Rowde House High Street Rowde SN10 2ND Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 29818200001 | |||||
| LIGHTFOOT, Jeremy | Director | 135 Windsor Road LU7 9GG Pitstone Buckinghamshire | England | British | 106933400002 | |||||
| NG, Nadine Loon Angela | Director | 1 Lumwood Smithills BL1 6TZ Bolton Lancashire | England | British | 28959860001 | |||||
| NG, Nadine Loon Angela | Director | 1 Lumwood Smithills BL1 6TZ Bolton Lancashire | England | British | 28959860001 | |||||
| PACKHAM, Thomas William George | Director | Church Cottage Church Lane Mamble DY14 9JY Kidderminster | British | 81029220001 | ||||||
| SLATER, David | Director | 7 High Road Londonthorpe NG31 9RU Grantham | British | 51860560002 | ||||||
| TEMPLE-HEALD, Nicholas | Director | The Downe Arms Church Lane YO25 5XD Little Driffield East Yorkshire | United Kingdom | British | 74074550002 | |||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glendale Grounds Management Limited | 06 abr 2016 | Berkeley Drive Bamber Bridge PR5 6BY Preston Parkwood House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene GLENDALE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 11 may 2007 Entregado el 23 may 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 07 may 2002 Entregado el 17 may 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0