IMRIE STEWART LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | IMRIE STEWART LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03196818 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IMRIE STEWART LIMITED?
- Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (81100) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra IMRIE STEWART LIMITED?
Dirección de la sede social | Servest House Heath Farm Business Centre Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Suffolk |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMRIE STEWART LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
WARMSTART PLC | 03 may 1996 | 03 may 1996 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IMRIE STEWART LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para IMRIE STEWART LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMRIE STEWART LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 02 sept 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 30 sept 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Declan James Clarke como director el 30 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Richard Morgan como director el 07 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Middleton como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 031968180002 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 031968180003 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Declan James Clarke como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Dickson como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Stewart como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Belinda George como secretario | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Prince Consort House Albert Embankment London SE1 7TJ* el 16 jul 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Paul Middleton como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Phillip Morris como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Legge como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de IMRIE STEWART LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICKSON, Daniel | Secretario | Heath Farm Business Centre Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Servest House Suffolk | 184838730001 | |||||||
LEGGE, Robert | Director | Heath Farm Business Centre Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Servest House Suffolk | United Kingdom | British | Company Director | 71242880002 | ||||
MORRIS, Phillip James | Director | Heath Farm Business Centre Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Servest House Suffolk | England | British | Company Director | 154417440001 | ||||
DAVIES, Derrick Lloyd | Secretario | Tudor Barn Cowship Lane Cromhall GL12 8AY Wotton Under Edge Gloucestershire | British | Financial Adviser | 5916660002 | |||||
GEORGE, Belinda Mary | Secretario | Albert Embankment SE1 7TJ London Prince Consort House United Kingdom | British | 162982600001 | ||||||
STOLLIDAY, John David | Secretario | 41 Hillside Road AL5 4BS Harpenden Hertfordshire | English | Accountant | 26566640001 | |||||
SECRETAIRE LIMITED | Secretario designado corporativo | 3rd Floor 2 Luke Street EC2A 4NT London | 900011490001 | |||||||
CLARKE, Declan James | Director | Heath Farm Business Centre Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Servest House Suffolk | United Kingdom | Irish | Director | 187565910001 | ||||
DAVIES, Derrick Lloyd | Director | Tudor Barn Cowship Lane Cromhall GL12 8AY Wotton Under Edge Gloucestershire | United Kingdom | British | Financial Adviser | 5916660002 | ||||
MIDDLETON, Paul Christopher | Director | Heath Farm Business Centre Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Servest House Suffolk | United Kingdom | British | Company Director | 99603920003 | ||||
MORGAN, Paul Richard | Director | Blenheim 10 Thirsk Gardens Bletchley MK3 5HY Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | British | Engineer | 52314320001 | ||||
SHEEHY, John Patrick | Director | 7 Lyndon Avenue Hatchend Pinner HA5 4QF Harrow Middlesex | England | British | Engineer | 32571330001 | ||||
STEWART, Ian Keith Imire | Director | The Sergeant 117 Clos De Belvedere Fort George Guernsey Channel Islands | British | Company Director | 35869240003 | |||||
STEWART, Robert Maxwell Forres | Director | Nightingales Lane HP8 4SH Chalfont St. Giles Langlands Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Engineer | 90626710001 | ||||
STOLLIDAY, John David | Director | 41 Hillside Road AL5 4BS Harpenden Hertfordshire | England | English | Accountant | 26566640001 | ||||
TRUSSLER, John | Director | Cobblestones 8 Wood End Road AL5 3ED Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Non Executive Chairman | 14143510001 | ||||
MARRIOTTS LIMITED | Director designado corporativo | 2 Luke Street EC2A 4NT London | 900013400001 | |||||||
SECRETAIRE LIMITED | Director corporativo | 2nd Floor 123/125 City Road EC1V 1JB London | 41315550001 |
¿Tiene IMRIE STEWART LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 01 jul 2013 Entregado el 16 jul 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción An accession deed to a debenture dated 21 december 2012 (as amended, novated, supplemented, extended or restated, from time to time) creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of imrie stewart limited, as more particularly described in clause 6 of the accession deed. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 01 jul 2013 Entregado el 15 jul 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción As more particularly described in clause 2 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of imrie stewart limited.. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 21 oct 2003 Entregado el 11 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0