RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED

RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03200097
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wey Court West
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOUTHERN LAND DEVELOPMENTS LIMITED17 may 199617 may 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2017 au 30 dic 2017

    1 páginasAA01

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 jun 2016

    Estado de capital el 15 jun 2016

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 jun 2015

    Estado de capital el 12 jun 2015

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Paul Anthony Watkins como secretario el 15 jul 2014

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Paul Anthony Watkins como director el 15 jul 2014

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Towngate House 2-8 Parkstone Road Poole Dorset BH15 2PW a Wey Court West Union Road Farnham Surrey GU9 7PT el 30 jul 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 17 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 jun 2014

    Estado de capital el 23 jun 2014

    • Capital: GBP 6
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 17 may 2012

    16 páginasRP04

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    3 páginasSH10

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 jun 2012

    • Capital: GBP 6
    4 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    6 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAYLOR, Robert Mark
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    Director
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    EnglandBritish46522020003
    TAYLOR, Helen
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    Secretario
    5 The Green
    Bloxworth
    BH20 0AA Wareham
    Dorset
    British89688100002
    WATKINS, Paul Anthony
    Glenair Road
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    Secretario
    Glenair Road
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    British36877870003
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secretario designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BELL, Matthew Robin
    Flat 5 Thistle Court
    28 Warwick Road, Boscombe
    BH7 6LB Bournemouth
    Dorset
    Director
    Flat 5 Thistle Court
    28 Warwick Road, Boscombe
    BH7 6LB Bournemouth
    Dorset
    British99628170002
    HILL, Richard James Barclay
    8 Orchardleigh Park
    21 Dean Park Road
    BH1 1HX Bournemouth
    Dorset
    Director
    8 Orchardleigh Park
    21 Dean Park Road
    BH1 1HX Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish41718540001
    KEEYS, William Albert
    14 Woodlake Close
    BH17 9FE Poole
    Dorset
    Director
    14 Woodlake Close
    BH17 9FE Poole
    Dorset
    EnglandBritish99628190001
    WATKINS, Paul Anthony
    Glenair Avenue
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    Director
    Glenair Avenue
    Parkstone
    BH148AD Poole
    4
    Dorset
    United Kingdom
    British36877870004
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Director designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Wey Court West
    Surrey
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Union Road
    GU9 7PT Farnham
    Wey Court West
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalThe Companies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03404258
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene RENAISSANCE DEVELOPMENTS (SOUTHERN) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 28 oct 2004
    Entregado el 13 nov 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a land at manor farm site, dorchester road, frampton dorset by way of first fixed charge all the machinery and fixtures and fittings, all furniture furnishings equipment tools and other chattels, the rental income, by way of floating charge all the undertaking and all property.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 13 nov 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 18 sept 2003
    Entregado el 20 sept 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 20 sept 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 19 feb 2003
    Entregado el 21 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a tor sands hotel 8 sands road paignton title absolute t/n DN83974 together with all buildings fixtures and erections thereon; fixed charge all monies received under any policy of insurance,the goodwill of any business and any share held in any management company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 21 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 jun 2002
    Entregado el 09 jul 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 09 jul 2002Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 26 jun 2002
    Entregado el 09 jul 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal charge the property k/a southlands, northfield road, minehead, t/n ST149054, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 09 jul 2002Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 26 jun 2002
    Entregado el 09 jul 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal charge the property k/a rectory house hotel and adjoining land, northfield road, minehead, somerset, all the plant machinery and fixtures and fittings of the company, present and future, all furniture, furnishings, equipment, tools and other chattels;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 09 jul 2002Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 28 ago 2001
    Entregado el 04 sept 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Coram court and land on the west side of coram court sidmouth road lyme regis t/no;-DT276150 DT274706 all plant machinery fixtures and fittings furniture furnishings and equipment all goodwill rental income present and future and floating charge over undertaking and all property and assets not charged by way of fixed charge above.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Limited
    Transacciones
    • 04 sept 2001Registro de un cargo (395)
    Second legal charge
    Creado el 28 ago 2001
    Entregado el 01 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £225,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Coram court sidmouth road lyme regis dorset t/nos: DT276150 and DT274706 subject to a first charge dated 28TH august 2001 in favour of close brothers limited.
    Personas con derecho
    • John William Stenson and Judith Elizabeth Stenson
    Transacciones
    • 01 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 09 feb 2001
    Entregado el 17 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £225,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Coram court sidmouth road lyme regis dorset.
    Personas con derecho
    • J and J Stenson Limited
    Transacciones
    • 17 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage deed
    Creado el 22 may 1998
    Entregado el 23 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plots A1-A4 phase 1 section a pandbury bridport road dorchester. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 23 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of assignment
    Creado el 25 abr 1997
    Entregado el 30 abr 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All of the company's benefit, right, title and interest under arising out of or vested in the company pursuant to the development agreement of even date. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 abr 1997Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 12 nov 1996
    Entregado el 14 nov 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 14 nov 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0