03200294 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresa03200294 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03200294
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de 03200294 LIMITED?

    • (3420) /

    ¿Dónde se encuentra 03200294 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Waterloo Way
    Leicester
    LE1 6LP
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 03200294 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LAWRENCE AUTOMOTIVE LIMITED17 jul 199617 jul 1996
    28 VSQ LIMITED17 may 199617 may 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de 03200294 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2002

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para 03200294 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para 03200294 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Restauración por orden judicial

    4 páginasAC92

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Finalización de la liquidación

    1 páginasL64.07

    Orden del tribunal para liquidar

    1 páginasCOCOMP

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal

    2 páginas3.6

    legacy

    1 páginas405(2)

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal

    2 páginas3.6

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal

    2 páginas3.6

    Resumen de ingresos y gastos del administrador concursal

    2 páginas3.6

    Misceláneos

    Stat of affairs with f 3.10
    22 páginasMISC

    Informe del receptor administrativo

    6 páginas3.10

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas405(1)

    legacy

    9 páginas363s
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    annual-return18 jun 2004

    legacy

    363(287)

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 dic 2002

    19 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    8 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2001

    19 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de 03200294 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GUICE, Peter Anthony
    7 Slate Close
    Glenfield
    LE3 8QQ Leicester
    Leicestershire
    Secretario
    7 Slate Close
    Glenfield
    LE3 8QQ Leicester
    Leicestershire
    British60929640002
    BRIDGE, Peter John
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    Director
    9 Fairlight Drive
    Barnt Green
    B45 8TB Birmingham
    United KingdomBritish54098960002
    CRAWFORD, Andrew
    5 Tithby Road
    Bingham
    NG13 8GN Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    5 Tithby Road
    Bingham
    NG13 8GN Nottingham
    Nottinghamshire
    British87398990001
    CULLEN, Sean Anthony
    18 Woodpecker Close
    Bingham
    NG13 8QL Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    18 Woodpecker Close
    Bingham
    NG13 8QL Nottingham
    Nottinghamshire
    British104909670001
    GUICE, Peter Anthony
    7 Slate Close
    Glenfield
    LE3 8QQ Leicester
    Leicestershire
    Director
    7 Slate Close
    Glenfield
    LE3 8QQ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish60929640002
    SMITH, Robert Michael
    Goldingale
    Station Road
    CV35 8HF Claverdon
    Warwickshire
    Director
    Goldingale
    Station Road
    CV35 8HF Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritish82265810001
    TURNER, Clive Arnold
    3 Brookwood Drive
    B45 8GG Barnt Green
    West Midlands
    Director
    3 Brookwood Drive
    B45 8GG Barnt Green
    West Midlands
    EnglandBritish101570480001
    MATTHEWS, John Antony
    Courtyard House
    The Sands East End
    LE14 4PA Long Clawson
    Leicestershire
    Secretario
    Courtyard House
    The Sands East End
    LE14 4PA Long Clawson
    Leicestershire
    British100850140001
    VICTORIA SQUARE SECRETARIES LIMITED
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    Secretario corporativo
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    44748190001
    HUTCHISON, Robert Paul
    6 Shoal Creek
    Collingtree Park
    NN4 0YT Northampton
    Director
    6 Shoal Creek
    Collingtree Park
    NN4 0YT Northampton
    British48603510002
    KELLY, Peter
    56 Malvern Road
    West Bridgford
    NG2 7BD Nottingham
    Director
    56 Malvern Road
    West Bridgford
    NG2 7BD Nottingham
    British91116430001
    MASH, Julian Paul Vivian
    23 Norland Square
    W11 4PU London
    Director
    23 Norland Square
    W11 4PU London
    British29275230002
    MATTHEWS, Charles Lewis
    Old Red Lion
    Millers Lane Hornton
    OX15 6BS Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Old Red Lion
    Millers Lane Hornton
    OX15 6BS Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish162976900001
    MATTHEWS, John Antony
    Courtyard House
    The Sands East End
    LE14 4PA Long Clawson
    Leicestershire
    Director
    Courtyard House
    The Sands East End
    LE14 4PA Long Clawson
    Leicestershire
    British100850140001
    VICTORIA SQUARE DIRECTORS LIMITED
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    Director corporativo
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    44748210001
    VICTORIA SQUARE SECRETARIES LIMITED
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    Director corporativo
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    44748190001

    ¿Tiene 03200294 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 22 jul 1999
    Entregado el 03 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 03 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 jul 1999
    Entregado el 29 jul 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2004Nombramiento de un receptor o gerente (405 (1))
    • 14 nov 2007Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (405 (2))
      • Número de expediente 1
    Debenture
    Creado el 15 jul 1996
    Entregado el 17 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as 28 vsq limited) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 jul 1996
    Entregado el 18 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as 28 vsq limited) to the chargee pursuant to a deed of guarantee and indemnity of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • 3I Plcfor Itself and as Trustee for the Investors (Asdefined in an Investment Agreement of Even Date)
    Transacciones
    • 18 jul 1996Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 16 jul 2004Nombramiento de un receptor o gerente (405 (1))

    ¿Tiene 03200294 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    22 jul 1999Fecha del instrumento
    Administrador judicial nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Profesional
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Profesional
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    2
    FechaTipo
    08 dic 2009Inicio de la liquidación
    04 ago 2010Fecha de disolución
    20 abr 2010Conclusión de la liquidación
    09 oct 2009Fecha de la petición
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Profesional
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0