POWERMARQUE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPOWERMARQUE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03204406
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de POWERMARQUE LIMITED?

    • (5010) /
    • (5020) /

    ¿Dónde se encuentra POWERMARQUE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de POWERMARQUE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NEVRUS (680) LIMITED28 may 199628 may 1996

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de POWERMARQUE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2004

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para POWERMARQUE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Resoluciones

    Resolutions
    páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de re-registro

    RES02

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    legacy

    1 páginas652a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2004

    19 páginasAA

    legacy

    3 páginas363s

    legacy

    páginas363(288)

    legacy

    1 páginas225

    legacy

    7 páginas395

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    3 páginas363s

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de POWERMARQUE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Secretario
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    English94987030001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    Secretario
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    JAMES, Graham Philip
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    Director
    28 Alexander Chase
    CB6 3SW Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomEnglish94987030001
    VENSON GROUP PLC
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Director corporativo
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    119183190001
    VENSON HOLDINGS LIMITED
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    Director corporativo
    Venson House
    Esher Green
    KT10 8BH Esher
    Surrey
    116764790001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    LAW, Stuart Peter
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    Secretario designado
    3 Oakwood Court
    Gordon Road
    E4 6BX Chingford
    London
    British900005090001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Director
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Director
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    DALY, James
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    22 Derwent Close
    Little Chalfont
    HP7 9PG Amersham
    Buckinghamshire
    British62710230001
    DICKINSON, Roger Martin
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    Director
    36 Glapthorn Road
    PE8 4JQ Oundle
    Peterborough
    British91579530001
    DOONEY, Michael Martin
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    Director
    Greenstones Hall
    IRISH Glandore
    Co Cork
    Ireland
    Irish68419160001
    DUNNE, Matthew
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    14 Coulson Way
    Alconbury
    PE28 4WU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British80391440001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Director
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Director
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    GIBBONS, David Victor
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    Director designado
    Briarfields
    Plough Corner
    CO16 9LU Little Clacton
    Essex
    British900005080001
    LAWSON SMITH, Clive
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    Director
    Wasing Place
    Wasing Park
    RG7 4NG Aldermaston
    Berkshire
    British72186210005
    MELLOR, Christopher John
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    Director
    Redoaks
    Redoaks Hill
    CB10 2LY Ashdon
    Essex
    United KingdomUk97680390001
    PETTIFOR, Timothy John
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish40366940001
    SCRIVEN, Grant John Paul
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    Director
    Drury House Pitch Hill
    GU6 7NN Ewhurst
    Surrey
    United KingdomIrish28260840002
    WATSON, Charles Dishington
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    Director
    245 Hillmorton Road
    CV22 5BE Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish41054110001
    WILLIAMSON, Alister Wallace
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    Director
    Brendons Church Road
    GU20 6BT Windlesham
    Surrey
    British29612530001

    ¿Tiene POWERMARQUE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Account charge
    Creado el 07 oct 2004
    Entregado el 20 oct 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the deposit and all the entitlements to interest the rights to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capital Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 2004Registro de un cargo (395)
    Chattels mortgage
    Creado el 19 dic 2003
    Entregado el 09 ene 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the goods, vehicles and equipment details of which are set our in the sale afgreement, together with the operating instructions, handbooks, specifications and books pertaining thereto and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto.
    Personas con derecho
    • Fortis Lease UK Limited
    Transacciones
    • 09 ene 2004Registro de un cargo (395)
    Security assignment
    Creado el 19 dic 2003
    Entregado el 09 ene 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its right, title, benefit and interest, present and future, under or arising out of or in respect of the relevant agreements; in, to and in respect of the vehicles the subject of the relevant agreements; in, to and in respect of all and any proceeds of claims made under the insurance in respect of the vehicles. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fortis Lease UK Limited
    Transacciones
    • 09 ene 2004Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0